ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED

ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social
    Número da empresa SC096855
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    • Outras atividades de construção especializadas n.e. (43999) / Construção

    Onde fica ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/07/2018
    Próximas contas vencem em30/04/2019
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/07/2017

    Qual é o status da última declaração de confirmação para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até25/11/2019
    Próxima declaração de confirmação vence09/12/2019
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até25/11/2018
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Despacho judicial

    Order of court - dissolution void
    1 páginasOC-DV

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Conta final antes da dissolução em CVL

    21 páginasLIQ14(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ para 11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G2 3BZ em 30/09/2022

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD para 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ em 07/06/2022

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 50 Melville Street Edinburgh EH3 7HF Scotland para 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD em 01/07/2019

    2 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 23/04/2019

    LRESEX

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Carol Dora Brodie como diretor em 25/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Peter Trevor Reid como diretor em 25/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Alexander Mckinney como diretor em 22/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Graeme Leslie Hadden como diretor em 22/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Bruce Dickson como diretor em 22/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Patrick Robertson Gammell como diretor em 25/01/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/11/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Sarah Jane Spurgeon Grotrian como diretor em 02/11/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Graeme Leslie Hadden como diretor em 02/11/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Sarah Jane Spurgeon Grotrian como diretor em 15/09/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Dr Peter Trevor Reid como diretor em 15/09/2017

    2 páginasAP01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/07/2017

    31 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/11/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr David Bruce Dickson como diretor em 15/09/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr John Arthur Conway como diretor em 15/09/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Neil Woodcock como diretor em 01/10/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Graham John Thomson Forbes como diretor em 15/09/2017

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JEFFCOAT, David Charles Elessing
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    11th Floor, Room 1110
    Secretário
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    11th Floor, Room 1110
    238863640001
    CONWAY, John Arthur, The Very Reverend
    Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    8
    Scotland
    Diretor
    Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish239459530001
    WOODCOCK, Neil
    Lennox Row
    EH5 3HL Edinburgh
    3
    Scotland
    Diretor
    Lennox Row
    EH5 3HL Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish1198420001
    BEBER, Sheila Hemingway
    12 Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    Secretário
    12 Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    British56580001
    BRUCE, Alexander James Arbuthnot
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Secretário
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    British1286720002
    JEFFCOAT, Marilyn Annette
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    United Kingdom
    Secretário
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    United Kingdom
    British63483550003
    BARBER, Joe Millar
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    Diretor
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    British781870001
    BRODIE, Carol Dora, Lady
    Cobden Crescent
    EH9 2BG Edinburgh
    21
    Diretor
    Cobden Crescent
    EH9 2BG Edinburgh
    21
    United KingdomBritish133066050001
    BRUCE, Mary Hope
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Midlothian
    British56640001
    CROSFIELD, George Philip Chorley
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Midlothian
    British132990001
    DICKSON, David Bruce
    Millbank
    EH17 7GA Balerno
    13
    Scotland
    Diretor
    Millbank
    EH17 7GA Balerno
    13
    Scotland
    ScotlandBritish215033080001
    FORBES, Donald James
    33 Coates Gardens
    EH12 5LG Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    33 Coates Gardens
    EH12 5LG Edinburgh
    Midlothian
    British56600001
    FORBES, Graham John Thomson, The Very Reverend Dr
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Diretor
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    United KingdomBritish37943660001
    GAMMELL, Patrick Robertson
    The Old Manse
    Morham
    EH41 4LQ Haddington
    East Lothian
    Diretor
    The Old Manse
    Morham
    EH41 4LQ Haddington
    East Lothian
    ScotlandBritish285170001
    GROTRIAN, Sara Jane Spurgeon
    Castleview
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Midlothian
    Diretor
    Castleview
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Midlothian
    British125519150001
    GROTRIAN, Sarah Jane Spurgeon
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Castleview
    Scotland
    Diretor
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Castleview
    Scotland
    ScotlandBritish128914330001
    GUILD, Ivor Reginald
    The New Club
    86 Princes Street
    EH2 2BB Edinburgh
    Diretor
    The New Club
    86 Princes Street
    EH2 2BB Edinburgh
    United KingdomBritish41504740001
    HADDEN, Graeme Leslie
    Melville Street
    EH3 7HF Edinburgh
    50
    Scotland
    Diretor
    Melville Street
    EH3 7HF Edinburgh
    50
    Scotland
    ScotlandBritish222881990001
    JEFFCOAT, Marilyn Annette
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    Diretor
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    ScotlandBritish63483550005
    MARKS, Frederick Charles
    Dunkeld 33 Townhill Road
    KY12 0JD Dunfermline
    Fife
    Diretor
    Dunkeld 33 Townhill Road
    KY12 0JD Dunfermline
    Fife
    British135790001
    MCKINLAY, Peter, Cbe
    Braemoray
    11 Alexander Third Street
    HY3 9SD Kinghorn
    Fife
    Diretor
    Braemoray
    11 Alexander Third Street
    HY3 9SD Kinghorn
    Fife
    British60892980001
    MCKINNEY, John Alexander
    Edderston Ridge
    EH45 9NA Peebles
    9
    Scotland
    Diretor
    Edderston Ridge
    EH45 9NA Peebles
    9
    Scotland
    ScotlandBritish118061190002
    REID, Peter Trevor, Dr
    Cumin Place
    EH9 2JX Edinburgh
    19
    Scotland
    Diretor
    Cumin Place
    EH9 2JX Edinburgh
    19
    Scotland
    ScotlandBritish166999500002
    TUDOR, James Brian
    15 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    15 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Great BritainBritish56630001
    WALKER, William Alexander
    40 Cherry Tree Gardens
    EH14 5SP Balerno
    Midlothian
    Diretor
    40 Cherry Tree Gardens
    EH14 5SP Balerno
    Midlothian
    British56610001
    YOUNG, David Tod
    4 High Street
    Auchtermuchty
    KY14 7AT Cupar
    Fife
    Diretor
    4 High Street
    Auchtermuchty
    KY14 7AT Cupar
    Fife
    British56650001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    25/11/2016A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    23/04/2019Início da liquidação
    03/02/2024Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0