AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED

AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC097757
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    • (6712) /

    Onde fica AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WEST GEORGE STREET (317)10/03/198610/03/1986

    Quais são as últimas contas de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/10/2010

    Quais são as últimas submissões para AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Ata da reunião final da liquidação voluntária

    5 páginas4.26(Scot)

    Resolução de insolvência

    Resolution INSOLVENCY:Joint liquidators' statement of account approved
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 31/10/2011

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de 191 West George Street Glasgow G2 2LD em 11/11/2011

    2 páginasAD01

    legacy

    4 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    Nomeação de Femi Sobo-Allen como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Jeffrey Lader como secretário

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2010

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 22/02/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/03/2011

    Estado do capital em 16/03/2011

    • Capital: GBP 9,717,500
    SH01

    Nomeação de Paul Charles Whitehead como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Angus Rigby como diretor

    2 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2009

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 22/02/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Angus Michael Rigby em 09/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Jeffrey Lader em 09/03/2010

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Caroline Jane Bradley em 09/03/2010

    2 páginasCH01

    Contas preparadas até 31/10/2008

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 31/10/2007

    9 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    7 páginas363s

    Quem são os diretores de AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SOBO-ALLEN, Femi
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Secretário
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    161588210001
    BRADLEY, Caroline Jane
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Diretor
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    United KingdomBritish279883630001
    WHITEHEAD, Paul Charles
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Diretor
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    UkDual Nationality Canadian/American154025550001
    BRADLEY, Caroline Jane
    24 Lakeside View
    Rawdon
    LS19 6RN Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    24 Lakeside View
    Rawdon
    LS19 6RN Leeds
    West Yorkshire
    British60987050001
    CORNYN, John
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    Secretário
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    British584620001
    LADER, Jeffrey
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LD
    Secretário
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LD
    British91785040001
    LEITH, Daniel
    406 Elm Tree Court
    Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Secretário
    406 Elm Tree Court
    Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    British49922240002
    MCKENZIE, Helen Marie
    2 Seafield Court
    FK1 5JZ Falkirk
    Stirlingshire
    Secretário
    2 Seafield Court
    FK1 5JZ Falkirk
    Stirlingshire
    British68683150002
    MCSPORRAN, Archibald Campbell
    18 Broomlands Crescent
    PA8 7BN Erskine
    Renfrewshire
    Secretário
    18 Broomlands Crescent
    PA8 7BN Erskine
    Renfrewshire
    British1367200001
    MITCHELL, Fiona
    11 Charles Drive
    FK5 3HB Larbert
    Stirlingshire
    Secretário
    11 Charles Drive
    FK5 3HB Larbert
    Stirlingshire
    British68683100001
    NIKLAS, Elizabeth
    22 The Nautilus Building
    3 Myddelton Passage
    EC1R 1XW London
    Secretário
    22 The Nautilus Building
    3 Myddelton Passage
    EC1R 1XW London
    British76189520003
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    British39851670003
    STEADMAN, Valentine Germaine Cecile
    11 Titmore Green
    Little Wymondley
    SG4 7JT Hitchin
    Hertfordshire
    Secretário
    11 Titmore Green
    Little Wymondley
    SG4 7JT Hitchin
    Hertfordshire
    British81906140001
    SULLIVAN, Terence Michael
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    Secretário
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    British11433910001
    TRANTOR, Colin Grant
    25 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    Secretário
    25 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    British52881000001
    VARDY, Richard John
    Court Cottage
    Headley Road
    GU26 6DL Grayshott
    Surrey
    Secretário
    Court Cottage
    Headley Road
    GU26 6DL Grayshott
    Surrey
    British153085180001
    WOOD, David Roy
    6 Old School Field
    Springfield Green
    CM1 7HU Chelmsford
    Essex
    Secretário
    6 Old School Field
    Springfield Green
    CM1 7HU Chelmsford
    Essex
    British53910300001
    ANDERSON, Andrew John
    19 Chishill Road
    Heydon
    SG8 8PW Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    19 Chishill Road
    Heydon
    SG8 8PW Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish33765840001
    BARCLAY, James Christopher
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    Diretor
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish6395690001
    BARRA, Joseph Nicholas
    19 Corwin Court
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    Diretor
    19 Corwin Court
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    American77192110001
    BAYS, Rochelle
    26 St. James's Place
    SW1A 1NH London
    Diretor
    26 St. James's Place
    SW1A 1NH London
    American78861810001
    BOWES-LYON, David James
    Heriot Water
    EH38 5YE Heriot
    Midlothian
    Diretor
    Heriot Water
    EH38 5YE Heriot
    Midlothian
    ScotlandBritish50820001
    CARMICHAEL, William
    1 Glamis Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SQ Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    1 Glamis Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SQ Auchterarder
    Perthshire
    British105075920001
    CORNYN, John
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    Diretor
    78 Cromarty Road
    ML6 9RN Airdrie
    Lanarkshire
    British584620001
    COSSEY, Geoffrey William
    Weston House
    Tillington
    GU28 0RA Petworth
    West Sussex
    Diretor
    Weston House
    Tillington
    GU28 0RA Petworth
    West Sussex
    British37377430003
    DOWD, Kenneth Leslie
    1 Century Building Saint Marys
    Parsonage
    M3 2DD Manchester
    Diretor
    1 Century Building Saint Marys
    Parsonage
    M3 2DD Manchester
    Canadian74603280001
    DUVAR, Jeff
    Flat 1 Ifield Road
    SW10 9AD London
    Diretor
    Flat 1 Ifield Road
    SW10 9AD London
    Canadian78865510001
    FOULKES, Michael Alexander
    466a Shadwell Lane
    LS17 8BA Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    466a Shadwell Lane
    LS17 8BA Leeds
    West Yorkshire
    Canadian99246240002
    GARDNER, John Thomas
    Little Copthall Kings Lane
    Chipperfield
    WD4 9EN Kings Langley
    Hertfordshire
    Diretor
    Little Copthall Kings Lane
    Chipperfield
    WD4 9EN Kings Langley
    Hertfordshire
    American72893410001
    GILCHRIST, Graeme Elder, Col (Retired)
    50 Holmbush Road
    Putney
    SW15 3LE London
    Diretor
    50 Holmbush Road
    Putney
    SW15 3LE London
    EnglandBritish584650001
    GORMAN, Lon
    24 Sherwood Downs
    FOREIGN Park Ridge
    New Jersey 07656
    Usa
    Diretor
    24 Sherwood Downs
    FOREIGN Park Ridge
    New Jersey 07656
    Usa
    American76871250001
    HOPTON, David
    6 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    Diretor
    6 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish6395670001
    LEONARD, James Patrick
    104 Canoe Brook Lane
    07931 Far Hills
    New Jersey
    America
    Diretor
    104 Canoe Brook Lane
    07931 Far Hills
    New Jersey
    America
    American76387820001
    MARTIN, Ian James
    Domaine De Peyloubere
    32550 Pavie
    France
    Diretor
    Domaine De Peyloubere
    32550 Pavie
    France
    British33782910001
    MASRANI, Bharat Bhagwanzi
    Flat 6
    2 Avenue Road
    NW8 7PU London
    Diretor
    Flat 6
    2 Avenue Road
    NW8 7PU London
    British65691240002

    AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 20/11/2001
    Entregue em 29/11/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due in connection with the facility agreement
    Breve descrição
    Fixed charge over all sums and payments relating to any stocks in crest; all right title and interest in the money standing to the credit of the controlled accounts; all right(including property rights) title and interest in all securities held in each escrow account ; floating charge over all eligible stock held by the company in crest; all property rights or intesrt in crest; all sums and benefits becoming due by reason of the entitlement to stock in crest...see microfiche for full details.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 29/11/2001Registro de uma garantia (410)
    • 01/11/2011Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Criado em 14/02/1997
    Entregue em 25/02/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All stock or property etc.... see the mortgage charge document for full details.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/02/1997Registro de uma garantia (410)
    • 01/11/2011Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    Floating charge
    Criado em 14/02/1997
    Entregue em 18/02/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All eligble stock etc.... see the mortgage charge document for full details.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 18/02/1997Registro de uma garantia (410)
    • 12/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 16/12/1996
    Entregue em 24/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 24/12/1996Registro de uma garantia (410)
    • 12/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of set-off
    Criado em 29/12/1986
    Entregue em 06/01/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descrição
    All sums standing at the credit of the company with the bank on current account.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 06/01/1987Registro de uma garantia
    • 14/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Charge
    Criado em 29/09/1986
    Entregue em 13/10/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The beneficial interest of the company under a general trust deed 1.
    Pessoas com direito
    • The Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland
    Transações
    • 13/10/1986Registro de uma garantia
    • 18/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    General charge
    Criado em 10/06/1986
    Entregue em 24/06/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Beneficial interest of the company under a general trust deed.
    Pessoas com direito
    • The Stock Exchange
    Transações
    • 24/06/1986Registro de uma garantia
    • 18/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)

    AITKEN CAMPBELL & COMPANY LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    24/01/2013Data de dissolução
    31/10/2011Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0