MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC107209
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    • (7415) /

    Onde fica MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EWOS (ALNESS) LIMITED05/07/200405/07/2004
    AQUASCOT GROUP LIMITED27/06/199527/06/1995
    AQUASCOT MARKETING LIMITED19/10/198719/10/1987

    Quais são as últimas contas de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/12/2009

    Quais são as últimas submissões para MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 14/03/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/03/2011

    Estado do capital em 14/03/2011

    • Capital: GBP 438,812
    SH01

    Nomeação de Mr Douglas Low como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Roger Dart como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr John Alexander Christie como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Tarald Sivertsen como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Geir Sjaastad como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de William Young como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/12/2009

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 14/03/2010 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/12/2008

    16 páginasAA

    Nomeação de Roger John Dart como secretário

    2 páginasAP03

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Contas anuais preparadas até 30/12/2007

    15 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Quem são os diretores de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    Secretário
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    154184170001
    HOMBLE, Synne
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    Diretor
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    NorwayNorwegian131062490001
    LOW, Douglas Robert Duncan
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Diretor
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    ScotlandBritish108811280002
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    Secretário
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    British140170170001
    DART, Roger John
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    Secretário
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    British146392500001
    MACKAY, Heather Florence
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    Secretário
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    British67953990002
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Secretário
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    British67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Secretário
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    British80737760001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Secretário
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    AGNEW, Keith Dalway
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    Diretor
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    British45855000002
    FILS, Pierre Yves
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    Diretor
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    French32799380001
    HERRERA, Luis Javier
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Diretor
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Chilean98594970001
    LAWRIE, Charles Sharp
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    Diretor
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    British41249220002
    MEAKIN, Nicholas St John
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish35721600001
    MORALES, Francisco Miranda
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Diretor
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Chilean121143130001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Diretor
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Diretor
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    Diretor
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    ScotlandBritish80737760001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Diretor
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    ScotlandBritish80737760001
    PALMER, Ronald Mackay
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    Diretor
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    British49741450001
    PARRY, John
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    Diretor
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    British1087410001
    PAYNE, James Gladstone
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    Diretor
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    ScotlandBritish6196670001
    PHILLIPS, William Charles Henry
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    Diretor
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    British454980001
    REEVE, Andrew James
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    Diretor
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    British50186870002
    REX, Stepehen Charles
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    Diretor
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    British97608220001
    SINCLAIR, Charles John
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    Diretor
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    British50197000001
    SIVERTSEN, Tarald
    8286 Nordfold
    Norway
    Diretor
    8286 Nordfold
    Norway
    NorwayNorwegian134255990001
    SJAASTAD, Geir
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    Diretor
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    NorwayNorwegian133629360001
    SMITH, Philip
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    Diretor
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    British73918640001
    SOUTER, William Graham
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    Diretor
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    British4973520001
    STEIRO, Oystein
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Diretor
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian81729570001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    TAIT, Michael Laurence
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    Diretor
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish267768460002
    WHYTE, George Mccurrach Mcintosh
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    Diretor
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    United KingdomBritish85024920001
    WILLIAMS, Peter Clifford
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Diretor
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    British47212810004

    MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Standard security
    Criado em 04/04/1996
    Entregue em 11/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Units 12, 13, 14 and 15 teaninich industrial estate, alness.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/04/1996Registro de uma garantia (410)
    • 23/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Marine mortgage
    Criado em 29/01/1996
    Entregue em 05/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64 shares in the vessel "aqua-marra-lass".
    Pessoas com direito
    • Nws Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1996Registro de uma garantia (410)
    • 30/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 07/02/1995
    Entregue em 16/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fish farm at rhunahoarine point, kintyre, argyll.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/02/1995Registro de uma garantia (410)
    • 23/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 27/07/1994
    Entregue em 29/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Kellock Limited
    Transações
    • 29/07/1994Registro de uma garantia (410)
    • 13/06/1995Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/01/1996Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 07/09/1998Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 02/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 28/02/1994
    Entregue em 08/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Ross & Cromarty Enterprise Limited
    Transações
    • 08/03/1994Registro de uma garantia (410)
    • 12/06/1995Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/01/1996Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 07/09/1998Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 25/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Standard security
    Criado em 03/09/1993
    Entregue em 10/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Area of ground situated at rhunahoarine point, kintyre.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 10/09/1993Registro de uma garantia (410)
    • 25/04/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 31/08/1993
    Entregue em 03/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 03/09/1993Registro de uma garantia (410)
    • 15/06/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 21/10/1989
    Entregue em 26/10/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Highlands and Islands Development Board
    Transações
    • 26/10/1989Registro de uma garantia
    • 12/06/1995Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/01/1996Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 07/09/1998Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 25/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    • Possui alterações nas proibições Sim
    Bond & floating charge
    Criado em 03/06/1988
    Entregue em 14/06/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/06/1988Registro de uma garantia
    • 12/06/1995Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/01/1996Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 10/09/1998Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 23/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    • Possui alterações nas proibições Sim

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0