SCOTTISH SEAFOODS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SCOTTISH SEAFOODS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC118977 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
- Processamento e conservação de peixe, crustáceos e moluscos (10200) / Indústrias transformadoras
Onde fica SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| M M & S (2013) LIMITED | 10/07/1989 | 10/07/1989 |
Quais são as últimas contas de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2018 |
Quais são as últimas submissões para SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Conta final antes da dissolução em MVL (conta final anexa) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG para 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS em 14/05/2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 60-64 Port Street Annan Dumfriesshire DG12 6BW para C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG em 17/07/2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado do capital em 23/03/2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Jenny Nancy Loncaster como diretor em 25/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Timothy Mark Busby como diretor em 12/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2019 para 31/03/2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont como diretor em 04/07/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited como secretário em 04/07/2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Timothy Mark Busby como diretor em 31/12/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Malcolm Herbert Lofts como diretor em 31/12/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 10/07/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Diretor | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Secretário | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
| WRIGHT, James Leonard | Secretário | 32 Devonshire Avenue DN32 0BW Grimsby N.E. Lincolnshire | British | 714180001 | ||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretário nomeado | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretário | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretário | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire United Kingdom |
| 75197930001 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Diretor | Main Street Sicklinghall LS22 4AP Wetherby Park Grange West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Diretor | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| CANE, James Robert | Diretor | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| FLEAR, Frank Alan | Diretor | 93 High Street Waltham DN37 0PN Grimsby North East Lincolnshire | British | 2785880001 | ||||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Diretor | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Diretor | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | 58713750002 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Diretor | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| LEADBETTER, Stephen Paul | Diretor | Mill Lane Legbourne LN11 8LT Louth Allt-Nam-Breac Lincolnshire | England | British | 132911790001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Diretor | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Diretor | 37 Brigsley Road Waltham DN37 0JX Grimsby North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 31098840002 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Diretor | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | 185296540001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Diretor | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| RUFFELL WARD, Brian | Diretor | Tudor Garth 18a Stallingborough Road Healing DN41 7QN Grimsby North East Lincolnshire | British | 72694900001 | ||||||||||
| SUTHERLAND, Innes | Diretor | Sutherley Nook Elsham DN20 0RG Brigg North East Lincolnshire | England | British | 1064160001 | |||||||||
| THOMAS, Andrew George | Diretor | 14 Mount View Woodgates Lane HU14 3JG North Ferriby East Yorkshire | British | 40002910008 | ||||||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Diretor | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
| VINDEX LIMITED | Diretor nomeado | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 900003390001 | |||||||||||
| VINDEX SERVICES LIMITED | Diretor nomeado | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 900003380001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06/04/2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SCOTTISH SEAFOODS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 23/10/2008 Entregue em 05/11/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 21/03/2007 Entregue em 31/03/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 16/03/2006 Entregue em 29/03/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due under the finance documents | |
Breve descrição First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 12/12/2005 Entregue em 20/12/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 23/09/2002 Entregue em 03/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Tenants interest in the lease over goat island, stornoway. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 05/08/2002 Entregue em 13/08/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Legal mortgage over property; fixed charges over asets; floating charge over same. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 10/12/1998 Entregue em 18/12/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Tenants interest in the lease over goat island 1,stornoway. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge | Criado em 25/10/1998 Entregue em 09/11/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The land and premises in folio 28273,folio 33933,folio 3222, county down. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge | Criado em 25/10/1998 Entregue em 09/11/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Factory no.2,rooney road,kilkeel,county down. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge | Criado em 25/10/1998 Entregue em 09/11/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Factory no.1,harbour road,kilkeel,county down,northern ireland. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed charge on book debts | Criado em 25/10/1998 Entregue em 09/11/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição All the book debts of the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 25/10/1998 Entregue em 09/11/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
SCOTTISH SEAFOODS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0