UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED

UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaUNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC125587
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    • Atividades de consultoria de gestão, exceto gestão financeira (70229) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
    • Ensaios e análises técnicas (71200) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PINELAW LIMITED13/06/199013/06/1990

    Quais são as últimas contas de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2022

    Quais são as últimas submissões para UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2022

    16 páginasAA

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    2 páginasDS01

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2023 com atualizações

    4 páginasCS01

    Término da nomeação de Adam Rhys Wynne Hughes como diretor em 16/06/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Bruno Claudio Oliveira Teixeira como diretor em 23/05/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr James Innes Mackay como diretor em 19/08/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Frederic Castrec como diretor em 19/08/2022

    2 páginasAP01

    Registo da garantia SC1255870002, criada em 19/08/2022

    20 páginasMR01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp 6 Queens Road Aberdeen Scotland AB15 4ZT Scotland para Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park Kintore Inverurie AB51 0QP em 01/09/2022

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Philip Nicholas Lanigan como secretário em 19/08/2022

    2 páginasAP03

    Nomeação de Mr Philip Nicholas Lanigan como diretor em 19/08/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Steven John Costello como secretário em 19/08/2022

    1 páginasTM02

    Memorando e estatutos

    27 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2021

    23 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Mr Steven John Costello em 22/07/2022

    1 páginasCH03

    Satisfação total da garantia 1

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Caroline Allen como diretor em 07/12/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Paul Joseph Mcshane como diretor em 07/12/2021

    2 páginasAP01

    Nomeação de Bruno Claudio Oliveira Teixeira como diretor em 07/12/2021

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    Secretário
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    299618740001
    CASTREC, Frederic
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    Diretor
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    FranceFrench299627840001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    Diretor
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    EnglandBritish42734310002
    MACKAY, James Innes
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    Diretor
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    ScotlandBritish108844510001
    MCSHANE, Paul Joseph
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Diretor
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    EnglandIrish218498550002
    COSTELLO, Steven John
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    184502790001
    HAYHURST, Fred
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XH Sheffield
    Europa View
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XH Sheffield
    Europa View
    South Yorkshire
    United Kingdom
    159575580001
    MACLEOD, George Paterson
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretário
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30567150001
    MACLEOD, Kenneth George
    340 Queens Road
    AB15 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretário
    340 Queens Road
    AB15 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British603660001
    MACLEOD, Patricia Margaret
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretário
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30567160001
    MIDDLETON, Sandra Elizabeth
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Secretário nomeado
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000270001
    ROBINSON, Paul James
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    Secretário
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    British61464420001
    ALLEN, Caroline
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    Diretor
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    United KingdomBritish241814400001
    CAREY, Malcolm Timothy
    14111 Indian Wells Drive
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    Diretor
    14111 Indian Wells Drive
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    UsaAmerican135768760001
    COGZELL, Matthew James
    Moor Gate
    Portishead
    BS20 7FL Bristol
    6
    United Kingdom
    Diretor
    Moor Gate
    Portishead
    BS20 7FL Bristol
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish157755080001
    COWLEY, John Mitchell
    Hatch Place
    Lower Road
    SL6 9EJ Cookham
    9
    United Kingdom
    Diretor
    Hatch Place
    Lower Road
    SL6 9EJ Cookham
    9
    United Kingdom
    EnglandBritish153045530001
    DAVISON, Thomas Patrick
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XE Sheffield
    Europa Court
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XE Sheffield
    Europa Court
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish178471340001
    EVERETT, Alan
    Anfield,
    Balnabruach, Portmahomack
    IV20 1YN Tain
    Ross-Shire
    Diretor
    Anfield,
    Balnabruach, Portmahomack
    IV20 1YN Tain
    Ross-Shire
    United KingdomBritish91840790001
    LAAKE, Gregory Duane
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    Diretor
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    United StatesUnited States104309910001
    MACLEOD, George Paterson
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30567150001
    MACLEOD, Kathleen
    340 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    340 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1185750001
    MACLEOD, Kenneth George
    340 Queens Road
    AB15 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    340 Queens Road
    AB15 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British603660001
    MACLEOD, Patricia Margaret
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    145 Kings Gate
    AB2 6DL Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30567160001
    MCNIVEN, Alan Ross
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Diretor nomeado
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000280001
    MOKLAK, Paul Daniel
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Diretor
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish217770510001
    REED, JR, James Franklin
    Pine Arbor
    77066 Houston
    5419
    Texas
    United States
    Diretor
    Pine Arbor
    77066 Houston
    5419
    Texas
    United States
    UsaUnited States137281430001
    RHODES, Fiona Elizabeth
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Diretor
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish200869110001
    SMILEY, Mark Richard
    Bath Road
    SL1 3YD Slough
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Bath Road
    SL1 3YD Slough
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish194271890001
    SMITH, Michael Peter
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    Diretor
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    British65426730001
    SOOD, Amit Kumar
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    Diretor
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    EnglandBritish153181250001
    STUBBS, Colin
    1 Porterfield Bank
    IV2 3HL Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    1 Porterfield Bank
    IV2 3HL Inverness
    Inverness Shire
    British100665460001
    STUBBS, Susan
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    Diretor
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    United KingdomBritish169624400001
    TEIXEIRA, Bruno Claudio Oliveira
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    Diretor
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    PortugalPortuguese290495760001
    WALKER, Alexander Davidson
    Maa-Jaa
    Doocot Park
    AB45 1DW Banff
    Diretor
    Maa-Jaa
    Doocot Park
    AB45 1DW Banff
    British497950002
    WYNNE HUGHES, Adam Rhys
    Farrington Road
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    Diretor
    Farrington Road
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    EnglandBritish113722460001

    Quem são as pessoas com controle significativo de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    06/04/2016
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03335609
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 19/08/2022
    Entregue em 06/09/2022
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Alter Domus (Us) Llc (as Agent)
    Transações
    • 06/09/2022Registro de uma garantia (MR01)
    Floating charge
    Criado em 21/12/1992
    Entregue em 29/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/12/1992Registro de uma garantia (410)
    • 22/06/2022Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0