PINNACLE CELLULAR LIMITED

PINNACLE CELLULAR LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPINNACLE CELLULAR LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC127133
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2023

    Quais são as últimas submissões para PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2023

    5 páginasAA

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Alteração dos detalhes de Pinnacle Cellular Group Limited como pessoa com controlo significativo em 03/07/2023

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom para 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ em 04/07/2023

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Janine Butler como diretor em 23/11/2022

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2021

    5 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2020

    6 páginasAA

    Término da nomeação de David Nigel Evans como diretor em 23/02/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Janine Butler como diretor em 23/02/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2019

    4 páginasAA

    legacy

    256 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Endereço do domicílio registado alterado de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG para Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ em 14/05/2019

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Andrew Michael Yorston como diretor em 02/04/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Michael Anthony Henry Olivier como diretor em 02/04/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Diane Josephine Mcintyre como diretor em 16/03/2019

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro2357692
    75473330004
    OLIVIER, Michael Anthony Henry
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257268230001
    YORSTON, Andrew Michael
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257275320001
    COULL, Gillian Margaret
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Secretário
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British30641050001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Secretário
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Secretário
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretário
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Secretário
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secretário
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secretário nomeado
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretário
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WHEELER, David
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    Secretário
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    British102737470001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Diretor
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    British123612980001
    BARR, Duncan David Whyte
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Diretor
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British37411850001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Diretor
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BUTLER, Janine
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Diretor
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    EnglandBritish277534960001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Diretor
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Diretor
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    GOW, John Warrender
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    Diretor
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    British55207220001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Diretor
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Diretor
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HERROD, Harry Alan
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    Diretor
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    British93998280001
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    British65152940001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Diretor
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Diretor
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Diretor
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Diretor
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British74872510003
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish173703620001
    MCNEILL, Ronald
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    Diretor
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    British205550003

    Quem são as pessoas com controle significativo de PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    06/04/2016
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridade legalUnited Kingdom (Scotland)
    Local de registroCompanies House
    Número de registroSc123629
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    PINNACLE CELLULAR LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Bond & floating charge
    Criado em 27/02/1996
    Entregue em 04/03/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/03/1996Registro de uma garantia (410)
    • 28/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 23/11/1995
    Entregue em 29/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises, 27 union street, dundee.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/11/1995Registro de uma garantia (410)
    • 28/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 23/11/1995
    Entregue em 29/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises, 35 and 37A high street, ayr.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/11/1995Registro de uma garantia (410)
    • 28/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 14/04/1994
    Entregue em 26/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop 12 leven street, edinburgh.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 26/04/1994Registro de uma garantia (410)
    • 03/11/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 06/04/1991
    Entregue em 19/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transações
    • 19/04/1991Registro de uma garantia
    • 11/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0