CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC128650 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
- Outras instalações de construção (43290) / Construção
Onde fica CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 24 Blythswood Square G2 4BG Glasgow |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| WETPARK LIMITED | 22/11/1990 | 22/11/1990 |
Quais são as últimas contas de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Conta final antes da dissolução em CVL | 15 páginas | LIQ14(Scot) | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH Scotland para 24 Blythswood Square Glasgow G2 4BG em 21/03/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 09/02/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland para C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive Leith Edinburgh EH6 6JH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Millar Bryce Bonnington Bond 2 Anderson Place Leith Edinburgh EH6 5NP para C/O Millar & Bryce Ltd Floor 4, Ocean Point 1 94 Ocean Drive, Leith, Edinburgh EH6 6JH em 24/10/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 09/02/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cessação de Michael John Dyson como pessoa com controlo significativo em 01/06/2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 09/02/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 09/02/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP Scotland para Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Michael John Dyson em 13/08/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de 95 Westburn Drive Cambuslang Glasgow G72 7NA Scotland para Millar & Bryce Limited Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh EH6 5NP | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Michael John Dyson em 13/08/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Andy Dobing como diretor em 24/09/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael John Dyson como diretor em 13/08/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alastair Richard Gamage como diretor em 16/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Andy Dobing como diretor em 11/06/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 09/02/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Mel Butler como diretor em 29/01/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Quem são os diretores de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYSON, Michael John | Diretor | Thorncliffe Park Estate, Newton Chambers Road Chapeltown S35 2PH Sheffield 5 Park Square England | England | British | 73151180001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Secretário | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
| REID, Brian | Secretário nomeado | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||
| SMITH, Linda Helen | Secretário | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313940002 | ||||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Secretário | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | British | 313950002 | ||||||
| BUTLER, Mel | Diretor | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 187274630001 | |||||
| DOBING, Andrew Paul | Diretor | Bonnington Bond 2 Anderson Place EH6 5NP Leith C/O Millar Bryce Edinburgh | England | British | 202646660001 | |||||
| DONALD, Neil | Diretor | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 195321250001 | |||||
| EATOCK, Matthew Joseph | Diretor | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 187184300001 | |||||
| EBSWORTH, Ronald Edwin | Diretor | 6 Adair Place FK13 6RS Tillicoultry Clackmannanshire | British | 75543300002 | ||||||
| FLEMING, Adam | Diretor | 5 Langhill Drive Balloch G68 9AP Cumbernauld Lanarkshire | British | 109188480001 | ||||||
| FOTHERINGHAM, Colin George Ewing | Diretor | Pond View Drain Lane Holme On Spalding Moor YO43 4DQ York East Yorkshire | United Kingdom | British | 82642480001 | |||||
| GAMAGE, Alastair Richard | Diretor | Century Way Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 3310 United Kingdom | United Kingdom | British | 124982420001 | |||||
| GREENAWAY, Andrew Paul | Diretor | Langsett Road S6 2LW Sheffield Hillsborough Works South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 120869420001 | |||||
| HUDSON, Jonathan Adrian | Diretor | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 27743810004 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Diretor | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| MONRO, Richard Charles | Diretor | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | United Kingdom | British | 59480370001 | |||||
| SMITH, Linda Helen | Diretor | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313940002 | |||||
| SMITH, Ronnie Mckenzie | Diretor | 23 Chalton Road Bridge Of Allan FK9 4DX Stirling | Scotland | British | 313950002 | |||||
| WAGHORN, Iain Lawrence | Diretor | 98 Forfar Road DD4 7BG Dundee | Scotland | British | 40141580001 | |||||
| WAUGH, Joanne | Diretor nomeado | 27 Castle Street EH2 3DN Edinburgh | British | 900000070001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Michael John Dyson | 06/04/2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: British País de residência: England | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Miller Pattison Ltd | 06/04/2016 | Thorncliffe Park, Chapeltown S35 2PH Sheffield Unit 5 Park Square England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Criado em 21/04/1998 Entregue em 27/04/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 21/12/1992 Entregue em 05/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
CLYDE INSULATION CONTRACTS (UK) LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de credores |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0