KENT FACILITIES LIMITED

KENT FACILITIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKENT FACILITIES LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC136162
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KENT FACILITIES LIMITED?

    • Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias

    Onde fica KENT FACILITIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    56 George Street
    EH2 2LR Edinburgh
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KENT FACILITIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INFRATIL KENT FACILITIES LIMITED28/09/200528/09/2005
    PIK SERVICES LTD.02/04/199202/04/1992
    ST. VINCENT STREET (200) LIMITED23/01/199223/01/1992

    Quais são as últimas contas de KENT FACILITIES LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2026
    Próximas contas vencem em31/12/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2025

    Qual é o status da última declaração de confirmação para KENT FACILITIES LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até23/01/2026
    Próxima declaração de confirmação vence06/02/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até23/01/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para KENT FACILITIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2025

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Gary John Mccabe como diretor em 31/07/2025

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Jamie Macnamara como diretor em 31/07/2025

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2024

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2023

    2 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2023 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2022

    3 páginasAA

    Estado do capital em 10/03/2022

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2021

    7 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ para 56 George Street Edinburgh EH2 2LR em 28/09/2021

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2020

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2019

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2018

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2017

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Quem são os diretores de KENT FACILITIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MACNAMARA, Jamie
    George Street
    EH2 2LR Edinburgh
    56
    Scotland
    Diretor
    George Street
    EH2 2LR Edinburgh
    56
    Scotland
    ScotlandBritish261420540001
    BECKWITH, Sheena Marion
    2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    Secretário
    2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    British77381700001
    CHANDLER, Christopher James
    West Sanquhar Road
    KA8 9HP Ayr
    5d
    Ayrshire
    Secretário
    West Sanquhar Road
    KA8 9HP Ayr
    5d
    Ayrshire
    Other123137610001
    JOHNSTON, John Michael
    24 Auchendoon Crescent
    KA7 4AS Ayr
    Secretário
    24 Auchendoon Crescent
    KA7 4AS Ayr
    British37473910001
    MCLEOD, Grant Harrison
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secretário
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    152065120001
    REID, Douglas John
    2 Sandpiper Road
    PA12 4NB Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Secretário
    2 Sandpiper Road
    PA12 4NB Lochwinnoch
    Renfrewshire
    British35548380002
    SWEENIE, Andrew Graeme
    10 Three Sisters Court
    KA21 6HH Saltcoats
    Ayrshire
    Secretário
    10 Three Sisters Court
    KA21 6HH Saltcoats
    Ayrshire
    British115133890001
    WHITE, Joyce Helen
    10 Winton Circus
    KA21 5DA Saltcoats
    Ayrshire
    Secretário
    10 Winton Circus
    KA21 5DA Saltcoats
    Ayrshire
    British9504020001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secretário nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    BAILLIE, John
    24 Grangemuir Road
    KA9 1PX Prestwick
    Ayrshire
    Diretor
    24 Grangemuir Road
    KA9 1PX Prestwick
    Ayrshire
    United KingdomBritish96362840001
    BECKWITH, Sheena Marion
    2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    Diretor
    2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    Great BritainBritish77381700001
    BUCHANAN, Charles Robert Scouler
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish169638200001
    CLARKE, Matthew Norman
    Station Road West
    CT2 8WA Canterbury
    4 Westside Apartments
    Kent
    Diretor
    Station Road West
    CT2 8WA Canterbury
    4 Westside Apartments
    Kent
    United KingdomBritish133198550001
    COCHRANE, Iain William
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish147397050001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Diretor
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    DAVIES, Clive Bartlett
    85 Chadwick Place
    KT6 5RG Surbiton
    Surrey
    Diretor
    85 Chadwick Place
    KT6 5RG Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish74423920001
    FITZGERALD, Steven
    The Terrace
    Wellington 6011
    225
    Nzl
    Diretor
    The Terrace
    Wellington 6011
    225
    Nzl
    New ZealandAustralian103068260008
    HEALY, Brendan John Patrick
    19 Craigend Road
    KA10 6HD Troon
    Ayrshire
    Diretor
    19 Craigend Road
    KA10 6HD Troon
    Ayrshire
    ScotlandBritish34314170001
    HUDSON, Matthew Chance
    4051 Nw 101 Drive
    33065 Coral Springs
    Florida 33065
    Usa
    Diretor
    4051 Nw 101 Drive
    33065 Coral Springs
    Florida 33065
    Usa
    Canadian1405720006
    MACKINNON, Alan Barclay
    Manston
    CT12 5BL Ramsgate
    Kent International Airport
    Diretor
    Manston
    CT12 5BL Ramsgate
    Kent International Airport
    EnglandBritish183610880001
    MCCABE, Gary John
    George Street
    EH2 2LR Edinburgh
    56
    Scotland
    Diretor
    George Street
    EH2 2LR Edinburgh
    56
    Scotland
    ScotlandBritish139525550001
    MCNEE, David Blackstock, Sir
    68 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    Diretor
    68 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    British602790001
    MILLER, William Brown
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    Diretor
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    ScotlandBritish30221770001
    MORRISON, Hugh Richmond Lloyd
    126 Bolton Street
    FOREIGN Wellington
    New Zealand
    Diretor
    126 Bolton Street
    FOREIGN Wellington
    New Zealand
    New ZealandNew Zealander58007990001
    NEWMAN, David Arthur Ross
    123 Molesworth Street
    Thorndon
    Apartment 7d
    Wellington
    New Zealand
    Diretor
    123 Molesworth Street
    Thorndon
    Apartment 7d
    Wellington
    New Zealand
    New ZealandNew Zealander110839920003
    RIDLEY-SMITH, Paul
    97 The Terrace
    Wellington
    6001
    New Zealand
    Diretor
    97 The Terrace
    Wellington
    6001
    New Zealand
    New ZealandNew Zealander110646190001
    SEIDENSTUCKER, Matthias
    24 Mckinley Crescent
    Wellington
    New Zealand
    Diretor
    24 Mckinley Crescent
    Wellington
    New Zealand
    German74423970001
    WALKER, Philip James
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    AustraliaAustralian126555700001
    WALKER, Philip James
    148 Laurel Avenue
    Chelmer
    Queensland 4068
    Australia
    Diretor
    148 Laurel Avenue
    Chelmer
    Queensland 4068
    Australia
    AustraliaAustralian126555700001
    WELCH, Alastair James Macpherson
    Manston
    CT12 5BL Ramsgate
    Kent International Airport
    Diretor
    Manston
    CT12 5BL Ramsgate
    Kent International Airport
    United KingdomBritish183611050001
    WHITE, Joyce Helen
    10 Winton Circus
    KA21 5DA Saltcoats
    Ayrshire
    Diretor
    10 Winton Circus
    KA21 5DA Saltcoats
    Ayrshire
    ScotlandBritish9504020001
    WILSON, Thomas Mackenzie
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    ScotlandBritish45710950001
    WILSON, Thomas Mackenzie
    24 Hunter Crescent
    KA10 7AH Troon
    Ayrshire
    Diretor
    24 Hunter Crescent
    KA10 7AH Troon
    Ayrshire
    ScotlandBritish45710950001
    LYCIDAS NOMINEES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Diretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003280001

    Quem são as pessoas com controle significativo de KENT FACILITIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Manston Skyport Limited
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    06/04/2016
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaLimted Company
    País de registroScotland
    Autoridade legalUk Companies Acts
    Local de registroScotland
    Número de registroSc459586
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0