SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC140932 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Dalziel House Lark Way Strathclyde Business Park ML4 3RB Bellshill |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| NESSCO SERVICES LTD. | 20/03/2001 | 20/03/2001 |
| NEWOOD TELECOM LIMITED | 10/10/1996 | 10/10/1996 |
| WOODEND TELECOM LIMITED | 12/02/1993 | 12/02/1993 |
| KINOCLEM LIMITED | 28/10/1992 | 28/10/1992 |
Quais são as últimas contas de SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2012 |
Quais são as últimas submissões para SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 28/03/2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/10/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Gareth Robert Kirkwood como diretor em 12/04/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/10/2011 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Alan Smith como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Anthony Riley como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Gareth Robert Kirkwood como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/04/2010 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 5 páginas | MG03s | ||||||||||
legacy | 5 páginas | MG03s | ||||||||||
Nomeação de Mr Anthony John Riley como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Matthew Robinson Riley como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Booth como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Término da nomeação de Ronald Smith como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alastair Mills como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de David Lewis Mcglennon como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual encurtado de 30/04/2011 para 31/03/2011 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Secretário | Lindred Road Business Park BB9 6QH Nelson Daisy House Lancashire United Kingdom | British | 155966360001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Diretor | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Diretor | Lark Way Strathclyde Business Park ML4 3RB Bellshill Dalziel House | United Kingdom | British | 161803100001 | |||||
| BAIRD, Brian Alexander | Secretário | 4 Cheviot Drive G77 5AS Glasgow | British | 95529070001 | ||||||
| BOOTH, Andrew Arnold | Secretário | Cedar Gardens SG19 1EY Sandy 13 Bedfordshire | British | 150506120001 | ||||||
| MCINTYRE, Colin | Secretário | 473 Clarkston Road G44 3LW Glasgow Lanarkshire | British | 732300001 | ||||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Secretário | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| SINCLAIR, Martin Fraser | Secretário | 5 St Thomas Road EH9 2LQ Edinburgh Midlothian | British | 29990001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secretário | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS LLP | Secretário | 6th Floor 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza | 137701650001 | |||||||
| QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HG Edinburgh | 38051430002 | |||||||
| QUILL SERVE LIMITED | Secretário nomeado | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000590001 | |||||||
| DAVIDSON, Austin Rioch | Diretor | 1 Cairnie View Westhill AB32 6NB Aberdeen | United Kingdom | British | 933600002 | |||||
| FORBES, Robert Gordon | Diretor | 7 Woodville Place SG14 3NX Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | 50248110002 | |||||
| GARDINER, Jock Alistair | Diretor | Harlaw Road AB15 4YY Aberdeen 38 Aberdeenshire | United Kingdom | British | 122105600001 | |||||
| HART, Gordon | Diretor | 1 Glebe Street ML3 6PT Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | 1253700001 | |||||
| HOULDSWORTH, June | Diretor | Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road High Blantyre G72 9UY Glasgow | United Kingdom | British | 1376720001 | |||||
| INGLIS, Gordon | Diretor | 17 Loudoun Place Symington KA1 5RP Kilmarnock Ayrshire | British | 61519150001 | ||||||
| KIRKWOOD, Gareth Robert | Diretor | Lark Way Strathclyde Business Park ML4 3RB Bellshill Dalziel House | England | British | 174056480001 | |||||
| MCMILLAN, John | Diretor | 36 Abbotsford Crescent East Kilbride ML10 6EQ Strathaven Lanarkshire | British | 66148880001 | ||||||
| MILLS, Alastair Richard | Diretor | King William Street EC4N 7BF London 18 | England | British | 108612460001 | |||||
| MYATT, David James | Diretor | Cloak House Lumphanan AB31 4PS Banchory Kincardineshire | British | 54699080001 | ||||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Diretor | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| RENDALL, David Campbell | Diretor | 20 Martin Brae Ladywell West EH54 6ER Livingston West Lothian | British | 54070560001 | ||||||
| RILEY, Anthony John | Diretor | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire United Kingdom | England | British | 89230160001 | |||||
| SMITH, Ronald Watson | Diretor | King William Street EC4N 7BP London 18 | England | British | 62182300001 | |||||
| SMITH, Thomas Davie | Diretor | East Mains Inchmarlo AB31 4BG Banchory 11 Kincardineshire United Kingdom | Scotland | British | 933610006 | |||||
| QUILL FORM LIMITED | Diretor nomeado | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000580001 | |||||||
| QUILL SERVE LIMITED | Diretor nomeado | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 900000590001 |
SPIRITEL IP SOLUTIONS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Criado em 18/03/2010 Entregue em 06/04/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Floating charge | Criado em 02/06/2008 Entregue em 11/06/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Floating charge | Criado em 02/06/2008 Entregue em 11/06/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 02/06/2008 Entregue em 07/06/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Floating charge | Criado em 01/04/1998 Entregue em 07/04/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 25/06/1993 Entregue em 12/07/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The whole assets of the company. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0