ASHBOURNE GROUP UK LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ASHBOURNE GROUP UK LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC141431 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
- Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ASHBOURNE LIMITED | 04/11/1994 | 04/11/1994 |
| DALGLEN (NO. 504) LIMITED | 27/01/1993 | 27/01/1993 |
| ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED | 20/01/1993 | 20/01/1993 |
| DALGLEN (NO. 504) LIMITED | 25/11/1992 | 25/11/1992 |
Quais são as últimas contas de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2010 |
Quais são as últimas submissões para ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Aviso da conclusão do acordo voluntário | 6 páginas | 1.4(Scot) | ||||||||||
Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 17/08/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Aviso do relatório da reunião que aprova o acordo voluntário com os credores | 4 páginas | 1.1(Scot) | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland em 20/01/2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2012 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/09/2010 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de William Mcleish como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2011 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Midmer como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU em 27/07/2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 27/09/2009 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2010 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de um diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Lynn Fearn como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Quem são os diretores de ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Diretor | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Secretário | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secretário | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secretário | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secretário | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secretário | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretário | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304650001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secretário | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secretário | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secretário | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS | Secretário nomeado | 11 Glenfinlas Street Edinburgh Lothian | 900005750001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Diretor | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Diretor | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Diretor | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Diretor | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Diretor | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Diretor | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Diretor | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Diretor | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Diretor | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Diretor | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEARN, Lynn | Diretor | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FEENEY, Martin | Diretor | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Diretor | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Diretor | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FOULKES, Kamma | Diretor | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Diretor | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GUEST, Walter Henry | Diretor | Spindleberry Pine Avenue GU15 2LY Camberley Surrey | British | 4200040001 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Diretor | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Diretor | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Diretor | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LEVICK, Ann | Diretor | 57a Highlands Heath SW15 3TX London | British | 37880870004 | ||||||
| LOCK, Jason David | Diretor | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Diretor | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Diretor | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 |
ASHBOURNE GROUP UK LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of acquisition agreement | Criado em 01/02/1993 Entregue em 19/02/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição In the charge of acquisition agreement topco as beneficial owner charges by way of first fixed charge to the security agent as a continuing security fot the secured obligations the full benefit of the acquisition agreement and all thhe right title and interest whatsoever of topco therein (together the "charged property"). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
ASHBOURNE GROUP UK LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA) |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0