ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED

ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC141433
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DALGLEN (NO. 506) LIMITED25/11/199225/11/1992

    Quais são as últimas contas de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 31/08/2012

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Charles Lovett como diretor em 31/08/2012

    2 páginasAP01

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4(Scot)

    Aviso do relatório da reunião que aprova o acordo voluntário com os credores

    4 páginas1.1(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland em 20/01/2012

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 15/01/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/01/2012

    Estado do capital em 18/01/2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    18 páginasAA

    Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de William Mcleish como secretário

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 15/01/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Término da nomeação de Richard Midmer como diretor

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 193 Bath Street Glasgow G2 4HU em 28/07/2010

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Contas anuais preparadas até 27/09/2009

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010

    2 páginasCH01

    Nomeação de um diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Diretor
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretário
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretário
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretário
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secretário
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304690001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secretário
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretário
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    Secretário nomeado
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    900005750001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Diretor
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Diretor
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Diretor
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Diretor
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    Diretor
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    British53339290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Diretor
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Diretor
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Diretor
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Diretor
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Diretor
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GUEST, Walter Henry
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    Diretor
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    British4200040001
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Diretor
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Diretor
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Diretor
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Diretor
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Diretor
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001

    ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of accession and charge
    Criado em 21/08/2008
    Entregue em 03/09/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/09/2008Registro de uma garantia (410)
    • 10/09/2008
    Legal charge
    Criado em 02/09/1996
    Entregue em 18/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charges.collingwood grange,portsmouth road,camberley,surrey. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transações
    • 18/09/1996Registro de uma garantia (410)
    • 12/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/02/1995
    Adquirido em 03/02/1995
    Entregue em 12/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due, or to become due
    Breve descrição
    Annfield house, stirling, registered under title number stg 9911.
    Pessoas com direito
    • Cala Management Limited
    Transações
    • 12/04/1995Registro de uma aquisição (416)
    • 18/02/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage
    Criado em 19/04/1994
    Entregue em 22/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Broomcroft, ecclesall road, south sheffield, south yorkshire.... See ch microfiche.
    Pessoas com direito
    • Electra Kingsway Limited as Agent and Trustee
    Transações
    • 22/04/1994Registro de uma garantia (410)
    • 29/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Legal charge
    Criado em 09/06/1993
    Entregue em 25/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    174 norwich road, ipswich and 176-182 (even nos) norwich road, ipswich.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 25/06/1993Registro de uma garantia (410)
    • 29/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 01/02/1993
    Adquirido em 01/02/1993
    Entregue em 11/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Broomcroft eccleshall road south sheffield and 12 other properties see paper apart 2.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transações
    • 11/03/1993Registro de uma aquisição (416)
    • 19/02/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 12/03/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 03/03/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 01/02/1993
    Entregue em 12/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Area of ground at torr road, quarrier's village, bridge of weir registered title number ren 58217 together with the mines, minerals, metals and fossils within and under the said subjects but that only in so far as the company has right thereto, the whole buildings and other erections if any to be erected thereon, the heritable fittings and fixtures therein and thereon and the parts, pertinents and priveleges thereof.
    Pessoas com direito
    • Electra Kingsway as Agent and Trustee
    Transações
    • 12/02/1993Registro de uma garantia (410)
    • 08/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Fixed charge
    Criado em 01/02/1993
    Entregue em 04/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    A. by way of legal mortgage the mortaged propery as listed in the paper apart, together with all fixed plant and machinery and fixtures thereto. B. by way of specific equitable charge all estates or interests in any freehold or leasehold property (except the mortgaged property and any such property as may be situated in scotland) now or at any time during the subsistence of the charge belonging to or charged to the company.
    Pessoas com direito
    • Electra Kingsway Limitedas Agent and Trustee for the Lenders
    Transações
    • 04/02/1993Registro de uma garantia (410)
    • 29/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 01/02/1993
    Entregue em 04/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Electra Kingsway Limitedas Agent and Trustee for the Lenders
    Transações
    • 04/02/1993Registro de uma garantia (410)
    • 12/02/1993Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/12/1993Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (419b)
    • 29/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim

    ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0