CIBOODLE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CIBOODLE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC143434 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CIBOODLE LIMITED?
- Desenvolvimento de software empresarial e doméstico (62012) / Informação e comunicação
Onde fica CIBOODLE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CIBOODLE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| GRAHAM TECHNOLOGY PLC | 26/01/1994 | 26/01/1994 |
| IAIN GRAHAM CONSULTANTS LIMITED | 24/03/1993 | 24/03/1993 |
Quais são as últimas contas de CIBOODLE LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/01/2016 |
Quais são as últimas submissões para CIBOODLE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Douglas Edward Robinson em 18/09/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Peter Demian Fante em 18/09/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr David Peter Outram em 18/09/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Douglas Edward Robinson em 18/09/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Peter Demian Fante em 24/07/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cessação de Verint Systems Inc como pessoa com controlo significativo em 14/07/2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notificação de Verint Ws Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 14/07/2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Estado do capital em 24/05/2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2017 com atualizações | 8 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/01/2016 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/03/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Douglas Edward Robinson como diretor em 04/11/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Peter Demian Fante como diretor em 04/11/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jeff Jackson Wylie como diretor em 04/11/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kenneth Bain como diretor em 04/11/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Peter Outram como diretor em 04/11/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/01/2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de John Arthur Murray como diretor em 06/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de John Arthur Murray como secretário em 06/04/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Quem são os diretores de CIBOODLE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTE, Peter Demian | Diretor | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire | United States | American | 287407380001 | |||||
| OUTRAM, David Peter | Diretor | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire | England | British | 44819540002 | |||||
| ROBINSON, Douglas Edward | Diretor | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire | United States | American | 97222830005 | |||||
| BAIN, Kenneth | Secretário | 16 Brierie Hill Grove Crosslee PA6 7BW Johnstone Renfrewshire | British | 171274100001 | ||||||
| MURRAY, John Arthur | Secretário | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire | British | 171294630001 | ||||||
| NORGATE, Philip Neil | Secretário | International House 1 St Katherines Way E1W 1UN London Sword Tech | British | 116191810001 | ||||||
| REID, Brian | Secretário nomeado | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||
| SIMPSON, Ellis | Secretário | 4 Langtree Avenue Giffnock G46 7LW Glasgow East Renfrewshire | British | 30856350001 | ||||||
| ANDERSON, William | Diretor | 2 Langhill Drive Cumbernauld G68 9AP Glasgow | British | 35116780001 | ||||||
| BAIN, Kenneth | Diretor | PA4 9LH Inchinnan India Of Inchinnan Renfrewshire United Kingdom | United Kingdom | British | 171274100001 | |||||
| BAIN, Kenneth | Diretor | 16 Brierie Hill Grove Crosslee PA6 7BW Johnstone Renfrewshire | United Kingdom | British | 171274100001 | |||||
| BERRY, Joseph Michael | Diretor | 21 Netherhouse Avenue Lenzie G66 5NF Glasgow | British | 35116770001 | ||||||
| BRIERCLIFFE, Michael James | Diretor | 8 Calverley Court Woodlesford LS26 8JE Leeds West Yorkshire | England | British | 6525440001 | |||||
| CAMILLERI, Mark | Diretor | Strathview Gillburn Road PA13 4DL Kilmacolm Renfrew | Australian | 79912940001 | ||||||
| DAVIES, Heath John | Diretor | Castelnau Barnes SW13 9EX London 46 | United Kingdom | British | 105007360002 | |||||
| DONNELLY, Colin | Diretor | 10 Arnside Avenue Giffnock G46 7QQ Glasgow | British | 35116870001 | ||||||
| FAIRBAIRN, Roger William | Diretor | Davos Wateryetts Drive Port Glasgow Road PA13 4QH Kilmacolm Renfrewshire | Australian | 66193820001 | ||||||
| FEICHTMANN, William Howard | Diretor | India Of Inchinnan Inchinnan PA4 9LH Renfrewshire | Usa | American | 171273880001 | |||||
| FILLOT, Francoise Marie | Diretor | 286 Route De La Glande FRANCE Limonest 69760 France | France | French | 76010150001 | |||||
| FORSYTH, Kenny Iain | Diretor | Flat 6/2 15 Clarendon Street G20 7QP Glasgow | British | 77084320001 | ||||||
| FOX, Brian Michael | Diretor | 1a Burnside Road Whitecraigs G46 6TT Glasgow | Scotland | British | 77462020001 | |||||
| FOX, Brian Michael | Diretor | 1a Burnside Road Whitecraigs G46 6TT Glasgow | Scotland | British | 77462020001 | |||||
| GRAHAM, Iain Mackenzie | Diretor | Killochries Fold PA13 4RP Kilmacolm Renfrewshire | Scotland | Scottish | 45372640001 | |||||
| GRAHAM, Sheena Margaret | Diretor | Killochries Fold PA13 4RP Kilmacolm Renfrewshire | Scotland | British | 45372600001 | |||||
| HAIGHTON, Stephen Arthur | Diretor | Preston Hill Farm Wootton Wawen B95 6ES Henley In Arden Warwickshire | United Kingdom | British | 115300460001 | |||||
| HUGHES, Michael | Diretor | 24 Branklyn Crescent Knightswood G13 1GJ Glasgow | British | 35176580002 | ||||||
| KIRWAN, Francis Xavier | Diretor | Gateside House Hill Road EH31 2BE Gullane East Lothian | British | 61709530001 | ||||||
| LYONS, David Richard Blair | Diretor | Pacemuir Road PA13 4JJ Kilmacolm Greenways Renfrewshire | United Kingdom | British | 139491910001 | |||||
| MABBOTT, Stephen | Diretor nomeado | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow Strathclyde | British | 900007110001 | ||||||
| MACAULAY, Dugald Macdonald | Diretor | 16 Churchill Drive G11 7LS Glasgow Lanarkshire | British | 345960001 | ||||||
| MCCLELLAND, Anthony Joseph | Diretor | Flat 11 247 Garrioch Road G20 8QZ Glasgow | British | 92272910001 | ||||||
| MCGOWN, Ross | Diretor | India Of Inchinnan PA4 9LH Inchinnan Renfrewshire | British | 77084370002 | ||||||
| MCINTOSH, Charles | Diretor | 11 Boggknowe Uddingston G71 7BL Glasgow | British | 35116830001 | ||||||
| MCKEE, David Russell | Diretor | 9 Lochaber Road Bearsden G61 2JX Glasgow | British | 55865950001 | ||||||
| MCLELLAN, Mairi Louise | Diretor | Millig Baek 23 Victoria Road G84 7RT Helensburgh Dunbartonshire | British | 118309030001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CIBOODLE LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verint Ws Holdings Limited | 14/07/2017 | Brooklands Road KT13 0RH Weybridge 241 Surrey United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Verint Systems Inc | 25/05/2016 | Broadhollow Road, Suite 100 Melville 11747 New York 175 Usa | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Edgar Acquisition Company Limited | 06/04/2016 | Greenock Road PA4 9LH Renfrew India Of Inchinnan United Kingdom | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CIBOODLE LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Criado em 27/07/2012 Entregue em 15/08/2012 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 07/03/2003 Entregue em 07/03/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Two plots or areas of ground etending to five acres and 748 decimal or one thousandth parts of an acre, both lying within inchinnan business park in the county of renfrew--title number REN101348. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 04/02/2003 Entregue em 10/02/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 30/07/2001 Entregue em 07/08/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Two areas of ground lying within inchinnan business park, renfrew. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 24/07/2001 Entregue em 07/08/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 19/06/2001 Entregue em 05/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Two areas of ground at inchinnan business park, renfrew extending to 5.748 acres and 3.219 acres. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 28/02/2001 Entregue em 06/03/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 10/02/2000 Entregue em 18/02/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Phase 1, inchinnan business park. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 29/03/1993 Entregue em 13/04/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0