STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSTRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC153127
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    • (4521) /

    Onde fica STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DUNWILCO (416) LIMITED16/09/199416/09/1994

    Quais são as últimas contas de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    legacy

    3 páginasMG03s

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Approve sale entire share capital of subsidiary 07/09/2011
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Approve sale entire share cap of subsidiary 06/09/2011
    RES13

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    11 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    4 páginasMG05s

    legacy

    4 páginasMG05s

    Declaração anual preparada até 27/07/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/08/2011

    Estado do capital em 03/08/2011

    • Capital: GBP 500
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Share purchase agreement approved 28/01/2011
    RES13

    legacy

    3 páginasMG02s

    Declaração anual preparada até 27/07/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Término da nomeação de David Gaffney como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    13 páginasAA

    Nomeação de Mr Colin Edward Lewis como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Neil Fitzsimmons como diretor

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ em 02/02/2010

    1 páginasAD01

    Detalhes do diretor alterados para David Gaffney em 29/01/2010

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808750001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LEES, Gordon
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    Secretário
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    British82127910001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secretário
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretário
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secretário
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secretário nomeado
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Diretor
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    British1198020003
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British43500170001
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Diretor nomeado
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FRASER, Gordon Mackenzie
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    Diretor
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    British16138750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Diretor nomeado
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Diretor
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    OGILVIE, Stuart
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    Diretor
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    British39560000001
    WHITAKER, David Alexander
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Diretor
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    ScotlandBritish26878690001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Diretor
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001

    STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 16/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 21/09/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Shares pledge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Breve descrição
    900 ordinary shares in castlegait homes limited.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Shares pledge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    12,100 ordinary shares over glademartin homes limited.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 24/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Floating charge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 14/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 21/09/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 08/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 26/09/2001
    Entregue em 04/10/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/10/2001Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Bond & floating charge
    Criado em 03/02/1995
    Entregue em 14/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/02/1995Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/07/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0