SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC155408
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    • (1598) /

    Onde fica SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Third Floor West Edinburgh Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SPEYSIDE GLENLIVIT WATER COMPANY LIMITED21/03/199521/03/1995
    M M & S (2247) LIMITED18/01/199518/01/1995

    Quais são as últimas contas de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2006

    Quais são as últimas submissões para SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Conta final antes da dissolução em CVL

    12 páginasLIQ14(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de * Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG* em 13/03/2013

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de * 2Nd Floor, Capital House 2 Festival Square Edinburgh Midlothian EH3 9SU* em 25/01/2012

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Invocas 2Nd Floor, Langstane House 221/229 Union Street Aberdeen AB11 6DR* em 15/04/2011

    2 páginasAD01

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    11 páginas2.25B(Scot)

    Relatório de progresso do administrador

    11 páginas2.20B(Scot)

    legacy

    2 páginas2.18B(Scot)

    Relatório de progresso do administrador

    8 páginas2.20B(Scot)

    legacy

    19 páginas2.18B(Scot)

    Declaração da proposta do administrador

    13 páginas2.16B(Scot)

    Nomeação de um administrador

    3 páginas2.11B(Scot)

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas410(Scot)

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2006

    14 páginasAA

    legacy

    42 páginas363a

    legacy

    3 páginas88(2)R

    legacy

    1 páginas288c

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2005

    15 páginasAA

    legacy

    6 páginas410(Scot)

    legacy

    3 páginas419a(Scot)

    legacy

    42 páginas363a

    legacy

    3 páginas88(2)R

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Quem são os diretores de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Secretário
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    British7130710001
    DRESHER, Leontina Megan
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    Diretor
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    United KingdomHungarian30141330001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish73146560001
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Diretor
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    EnglandBritish7130710001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Secretário
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Secretário
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    British70901470001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Secretário
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    British61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Secretário
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    British57563390001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Secretário
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secretário
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secretário
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretário nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, John Arthur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    Diretor
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    EnglandBritish34883320001
    BEVAN, Jonathan Stuart Vaughan
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    Diretor
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    British39232450001
    CHILD, Peter John
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    Diretor
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    British24036010001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Diretor
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    COURTNEY, John Adam
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    British15297560005
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Diretor
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish70901470001
    EVERETT, Grace Mary
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Diretor
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    British70901230001
    EVERETT, Timothy John
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Diretor
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish70901170001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Diretor
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritish38497170001
    HEINRICH, Gisbert
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    Diretor
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    British44530030001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Diretor
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    EnglandBritish61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Diretor
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish57563390001
    MARNER, Christian
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Diretor
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Danish52354890003
    MILLAR, Andrew Donaldson
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Diretor
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    British116870001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Diretor
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritish14578540001
    SULLY, Malcolm Keith
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Diretor
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    British39278310002
    WOOD - ROBERTS, David
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    Diretor
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    British64744510006
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Diretor nomeado
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Diretor nomeado
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 12/03/2008
    Entregue em 02/04/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Floating charge over 1 x 2007 zambelli fully automatic trayloader/shrink wrapping machine, model number LFT20/v single lane version - serial number 4621.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Commercial Asset Finance (UK) Limited
    Transações
    • 02/04/2008Registro de uma garantia (410)
    Floating charge
    Criado em 02/11/2006
    Entregue em 22/11/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    As continuing security for the payment or discharge othe secured liabilities all of the equipment and other chattels. See form 410 for further details.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Davenham Trust PLC
    Transações
    • 22/11/2006Registro de uma garantia (410)
    Bond & floating charge
    Criado em 29/04/2004
    Entregue em 14/05/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/05/2004Registro de uma garantia (410)
    Floating charge
    Criado em 10/09/1999
    Entregue em 23/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Speyside Glenlivet Limited
    Transações
    • 23/09/1999Registro de uma garantia (410)
    • 30/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    05/03/2009Início da administração
    04/03/2010Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Profissional
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Profissional
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    2
    DataTipo
    04/03/2010Início da liquidação
    14/11/2020Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Profissional
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Profissional
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0