CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC158880
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    • Hotéis e alojamentos semelhantes (55100) / Alojamento, restauração e similares

    Onde fica CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CITY INN LIMITED28/09/200028/09/2000
    FIRST STOP HOTELS LIMITED27/06/199527/06/1995

    Quais são as últimas contas de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Nomeação de Mr Raymond Annel Marquis como diretor em 22/11/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Emma Jane Morton como diretor em 22/11/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Panayot Kostadinov Vasilev como diretor em 22/11/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Simon David Austin Davies como diretor em 22/11/2019

    1 páginasTM01

    Conta final antes da dissolução em MVL (conta final anexa)

    8 páginasLIQ13(Scot)

    Término da nomeação de John Khay-Yan Wong como diretor em 17/04/2019

    1 páginasTM01

    Alteração dos detalhes de Mr Stephen Allen Schwarzman como pessoa com controlo significativo em 30/10/2018

    2 páginasPSC04

    Notificação de Stephen Allen Schwarzman como pessoa com controlo significativo em 30/10/2018

    2 páginasPSC01

    Nomeação de Mr John Khay-Yan Wong como diretor em 03/01/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Gabriel Petersen como diretor em 03/01/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 27/06/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/09/2016

    LRESSP

    Segunda apresentação da declaração anual até 27/06/2015

    23 páginasRP04AR01

    Declaração anual preparada até 27/06/2016

    21 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/08/2016

    Estado do capital em 16/08/2016

    • Capital: GBP 101,053
    SH01

    Satisfação total da garantia 25

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 27

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC1588800029

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 26

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC1588800030

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC1588800028

    1 páginasMR04

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name04/05/2016

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Nomeação de Mr Panayot Kostadinov Vasilev como diretor em 14/04/2016

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Gabriel Petersen em 16/04/2016

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon David Austin Davies em 16/04/2016

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secretário
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro08334728
    175738460001
    MARQUIS, Raymond Annel
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Diretor
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Director243770520001
    MORTON, Emma Jane
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Diretor
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Financial Controller264422520001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Secretário
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    British52526750008
    PAIN, Fennigje
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    Secretário
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    169634590001
    SALMER, Gabriele
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Secretário
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    163370600001
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secretário nomeado
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Diretor
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishBanker73849040001
    BRIANCE, Richard Henry
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritishEx-Banker16636440001
    CRERAR, William Gunn
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    BritishArchitect17957980002
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Diretor
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBank Official68241910003
    DAVIES, Simon David Austin
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Diretor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritishSenior Vice President147210490001
    FISKEN, Gillian Claire
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    Diretor
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    BritishC.A.128106370001
    GATELEY, Donald Kenneth
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Diretor
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker104442220001
    HEPBURN, Victor Alexander
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    Diretor
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    ScotlandBritishBanker161679840001
    HOOD, Lynn Catherine
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritishDirector Of Operations116713060003
    KANDRAC, Martin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomSlovakianManaging Director163382910001
    KATZ, Andrew
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Diretor
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomAmericanManaging Director163382710002
    MACDONALD, Angus Duncan Forbes
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritishAccountant93989850003
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Accountant43780001
    MANBY, Peter
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritishChief Operating Officer155467670001
    MATTHEWS, Janet
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    BritishOperations Director53862640001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritishLawyer52526750008
    MCKIE, Gordon Robert
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    Diretor
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    EnglandBritishVice President155757550001
    NORTH, Michael John
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    Diretor
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    BritishOperations Director89984500001
    O'CONNOR, Huw
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritishManaging Director74283080002
    ORR, David James Macconnell
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Diretor
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandBritishChief Executive100937170004
    ORR, James Alexander Macconnell
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritishSolicitor81233650001
    PETERSEN, Gabriel
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Diretor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritishManaging Director132466780002
    SHEARER, David James Buchanan
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritishChief Strategic Adviser161360020001
    SMITH OF GILMOREHILL, Elizabeth Margaret, Baroness Smith Of Gilmorehill
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritishPeer Of The Realm43044700001
    STARN, William Robert
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Diretor
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandAmericanFinance Director154007330001
    VASILEV, Panayot Kostadinov
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Diretor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBulgarianDirector206224490001
    WATSON, Stuart Iain
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Diretor
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker126792450001
    WONG, John Khay-Yan
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Diretor
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    EnglandBritishDirector226216750001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Stephen Allen Schwarzman
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    30/10/2018
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    Não
    Nacionalidade: American
    País de residência: United States
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 14/01/2015
    Entregue em 27/01/2015
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Mint hotel (formerly city inn hotel) finnineston quay, glasgow GLA148962.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Pessoas com direito
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transações
    • 27/01/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/12/2014
    Entregue em 24/12/2014
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Land to the west of neville street and land lying to the north canal wharf, leeds. Title numbers WYK842997 and WYK877560. Also all other plots of land listed on schedule 2 of the instrument.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transações
    • 24/12/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/12/2014
    Entregue em 24/12/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transações
    • 24/12/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 22/09/2011
    Entregue em 05/10/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Mint hotel (formerly the city inn hotel) finnieston quay glasgow gla 148962.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 05/10/2011Registro de uma garantia (MG01s)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement and deed of accession
    Criado em 15/09/2011
    Entregue em 05/10/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 05/10/2011Registro de uma garantia (MG01s)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 15/09/2011
    Entregue em 05/10/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 05/10/2011Registro de uma garantia (MG01s)
    • 22/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 08/12/2009
    Entregue em 10/12/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Land to west of neville street, leeds WYK877560.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/12/2009Registro de uma garantia (MG01s)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Legal charge
    Criado em 19/06/2009
    Entregue em 07/07/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    A lease of flat 107 millbank court, 24 john islip street, london and store room 107.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 07/07/2009Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Legal charge
    Criado em 26/03/2008
    Entregue em 26/03/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Granary wharf, leeds WYK843001 WYK842997 including fixed charges and assignment.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/03/2008Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Legal charge
    Criado em 10/01/2007
    Entregue em 11/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All that benefit of the chargors interest in the development agreement and all rights, titles, benefits and interests relating to the development agreement.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/01/2007Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Legal charge
    Criado em 10/01/2007
    Entregue em 11/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    By way of legal mortgage granary wharf, leeds WYK834117 and WYK651848 WYK724867 including fixed charges.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/01/2007Registro de uma garantia (410)
    • 31/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Legal charge
    Criado em 05/01/2007
    Entregue em 18/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over 39 crutched friars, london NGL749312.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 18/01/2007Registro de uma garantia (410)
    • 06/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Standard security
    Criado em 22/12/2006
    Entregue em 09/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The city inn hotel, finnieston quay, glasgow and ground at finnieston quay GLA148962.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/01/2007Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Legal charge
    Criado em 08/12/2006
    Entregue em 19/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Flat 107, millbank court, 24 john islip street & store room 107, london NGL320667; 25 savage gardens, london LN27259; hotel site, 31 aytoun street, manchester MAN22824; 30 john islip street, london LN96333 NGL795620; the city inn hotel, 1 brunswick square, brindleyplace, birmingham WM729821; land at temple way, bristol BL65802.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/12/2006Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Criado em 08/12/2006
    Entregue em 18/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 18/12/2006Registro de uma garantia (410)
    • 21/09/2011Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    Legal charge
    Criado em 07/11/2006
    Entregue em 09/11/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Leasehold property known as flat and store room 107, tenth floor, millbank court, 24 john islip street, london NGL320667.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/11/2006Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 14/10/2005
    Entregue em 27/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 27/10/2005Registro de uma garantia (410)
    • 07/12/2005Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 19/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 06/07/2005
    Entregue em 08/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descrição
    Legal mortgage over all that freehold property known as 25 savage gardens, london (title number LN27259); fixed and floating charges over assets.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 08/07/2005Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 03/06/2005
    Entregue em 08/06/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descrição
    Legal mortgage over all that leasehold land at piccadilly triangle demised by an underlease between piccadilly place trustee (no.1) limited and piccadilly place trustee (no.2) limited and city inn limited dated 2 june 2005; fixed and floating charges over assets.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 08/06/2005Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Legal charge
    Criado em 27/05/2004
    Entregue em 09/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Hotel site, piccadilly triangle, manchester.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/06/2004Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 18/04/2001
    Entregue em 20/04/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over the property (land at john islip street, london); fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/04/2001Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Legal charge
    Criado em 17/08/2000
    Entregue em 01/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 01/09/2000Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Legal charge
    Criado em 17/08/2000
    Entregue em 01/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 01/09/2000Registro de uma garantia (410)
    • 11/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 07/08/2000
    Entregue em 10/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/08/2000Registro de uma garantia (410)
    • 19/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/08/2000
    Entregue em 15/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Ground at finnieston quay, glasgow.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/08/2000Registro de uma garantia (410)
    • 19/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/09/2016Início da liquidação
    27/12/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0