CENTROS MILLER 1999 LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CENTROS MILLER 1999 LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC168068 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CENTROS MILLER LIMITED | 29/10/1996 | 29/10/1996 |
| DMWS 276 LIMITED | 04/09/1996 | 04/09/1996 |
Quais são as últimas contas de CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Conta final antes da dissolução em MVL (conta final anexa) | 14 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL para C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD em 10/10/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Paul Jonathan Goswell como diretor em 05/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Sutherland como diretor em 05/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH para 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL em 25/01/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 16/01/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2017 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 16/01/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Euan James Edward Haggerty como diretor em 30/06/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 16/01/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 16/01/2016 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Philip Hartley Miller como diretor em 31/05/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 16/01/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 16/01/2014 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2012 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Frederic Hewett como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 16/01/2013 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2011 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSWELL, Paul Jonathan | Diretor | 3 Scarth Road Barnes SW13 0ND London Westcott House United Kingdom | England | British | 202597650001 | |||||
| HADEN-SCOTT, Timothy | Diretor | Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London Delancey 6th Floor United Kingdom | England | British | 133382310002 | |||||
| MILLOY, David Thomas | Diretor | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Diretor | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | United Kingdom | British | 66368290003 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Secretário | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Secretário | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| ANDERSON, Philip Edward | Diretor | 13 The Priory RH9 8NL Godstone Surrey | British | 14687720001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Diretor | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BRUCE, Roderick Lawrence | Diretor nomeado | Rosehill 23 Inveresk Village Inveresk East Lothian | British | 900003110001 | ||||||
| FROST, Simon | Diretor | 32 Sidney Road KT12 2LZ Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | 16522420002 | |||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Diretor | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| HAMPSON, Lester Paul | Diretor | 21 Brassey Hill RH8 0ES Oxted Surrey | British | 97665250001 | ||||||
| HARRIS, Nicholas John | Diretor | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | 74890900001 | |||||
| HARRIS, Nicholas John | Diretor | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | 74890900001 | |||||
| HEWETT, Frederic Mark | Diretor | 16 The Drive TN9 2LP Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 52840680001 | |||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Diretor | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| LAKER, John Frederick | Diretor | 57 Greenways KT10 0QH Hinchley Woods Surrey | United Kingdom | British | 54651510001 | |||||
| MARSH, John Charles | Diretor | 115 Upper Grosvenor Road TN1 2EA Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 85346010001 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Diretor | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| MINTO, Bruce Watson | Diretor nomeado | 1 Wester Coates Road EH12 5LU Edinburgh | British | 900000330001 | ||||||
| O'REILLY-NEENAN, Marie Bernadette | Diretor | Ballymulcashel Kilmurry Sixmilebridge Ballymul House Ennis Co Clare Ireland | Irish | 135305100001 | ||||||
| ROBINSON, David | Diretor | 118 Meadowspot EH10 5UY Edinburgh Lothian | Scotland | United Kingdom | 50541770001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Diretor | 87 Whitehouse Road EH4 6PB Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | 66368290001 | |||||
| WHEELER, John Allan Campbell | Diretor | 23 South Square NW11 7AJ London | United Kingdom | British | 7882570001 | |||||
| WISE, Richard John | Diretor | 6 The Leas Longdean Park HP3 8BP Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 59140110002 | |||||
| WOOD, Marlene | Diretor | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centros Miller Holdings Limited | 06/04/2016 | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CENTROS MILLER 1999 LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security document | Criado em 12/05/2003 Entregue em 30/05/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Land & buildings at wide bargate, threadneedle street, pen street, main ridge west and mitre lane, boston, lincolnshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage of deposited monies | Criado em 04/01/2000 Entregue em 17/01/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição A book debt of £88,990 owing by hsbc bank PLC to centro miller limited standing to the credit of an interest earning bank account numbered 9246698 at hsbc bank PLC at its branch at holburn circus or such other account or accounts at any branch of hsbc bank PLC as may from time to time be submitted therefore whether by way of tranfer of monies redesignation or otherwise together with all further sums which may be credited to the account together with all interest accruing thereon and the due benefit and the advantage thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 18/11/1996 Entregue em 20/11/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
CENTROS MILLER 1999 LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0