STRATHTAY VENTURES LIMITED

STRATHTAY VENTURES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSTRATHTAY VENTURES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC171237
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRAVEHEART VENTURES LIMITED22/01/199722/01/1997
    NEWCO (507) LIMITED07/01/199707/01/1997

    Quais são as últimas contas de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2019

    Quais são as últimas submissões para STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/03/2019

    23 páginasAA

    legacy

    77 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaração de confirmação apresentada em 07/01/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Braveheart Investment Group Plc como pessoa com controlo significativo em 06/01/2019

    2 páginasPSC05

    Contas anuais preparadas até 31/03/2018

    25 páginasAA

    Nomeação de Gbac Limited como secretário em 01/02/2018

    2 páginasAP04

    Declaração de confirmação apresentada em 07/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 2 Dundee Road Perth PH2 7DW para 1 George Square Glasgow G2 1AL em 11/11/2017

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2017

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 07/01/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2016

    24 páginasAA

    Término da nomeação de Jeremy Delmar-Morgan como diretor em 31/07/2016

    1 páginasTM01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Declaração anual preparada até 07/01/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/01/2016

    Estado do capital em 08/01/2016

    • Capital: GBP 1,939,190
    SH01

    Término da nomeação de Geoffrey Charles Byars Thomson como diretor em 19/11/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2015

    27 páginasAA

    Nomeação de Mr Vivian David Hallam como diretor em 09/11/2015

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de Merlin House Necessity Brae Perth PH2 0PF para 2 Dundee Road Perth PH2 7DW em 22/06/2015

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Carolyn Smith como diretor em 06/05/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Aileen Brown como diretor em 20/04/2015

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GBAC LIMITED
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Secretário
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro04246760
    170866550001
    HALLAM, Vivian David
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Diretor
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    EnglandBritish91949990002
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Secretário
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    British949930002
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Secretário
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    166522140001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Secretário
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    British188230360001
    SMITH, Carolyn
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    Secretário
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    British90876900001
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    Secretário
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    British18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Secretário
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    British96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Secretário
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    British11753830002
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Secretário
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Diretor
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    ScotlandBritish949930002
    BAXTER, Edward Thomas
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    Diretor
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    ScotlandBritish36600150001
    BENSON, Matthew James
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    British30332650003
    BOGGS, Peter Lawson
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    Diretor
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    American72417090001
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Diretor
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish135871560003
    BROWN, John Kenneth
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Diretor
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish462890004
    CAMPBELL, Kenneth James
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish842260002
    CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    Diretor
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    ScotlandBritish49441240001
    CUNNINGHAM, Edward Brandwood
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Diretor
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish376910001
    DELMAR-MORGAN, Jeremy
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Diretor
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    United KingdomBritish23953030001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Diretor
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    United KingdomBritish188230360001
    HUGHES, James Michael
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    Diretor
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    ScotlandBritish107865020001
    MACASKILL, Alistair Angus
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    Diretor
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    British49154730001
    MACPHERSON, Agnes Lawrie Addie Shonaig
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    Diretor
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritish104298000001
    SMITH, Carolyn
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Diretor
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish90876900001
    STEWART, Robert Douglas
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    British51913570002
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Diretor
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    PerthBritish18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Diretor
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    United KingdomBritish96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Diretor
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    United KingdomBritish11753830002
    TURNER, Donald Ian
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    Diretor
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish172904550001
    WATSON, Garry Sanderson
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Diretor
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    EnglandBritish34442460001
    WATSON, Garry Sanderson
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    Diretor
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    EnglandBritish34442460001
    WEMYSS, Charles John
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    Diretor
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    United KingdomBritish732870002
    WEMYSS, Michael James
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    Diretor
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    United KingdomBritish227540002
    MBM BOARD NOMINEES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    42680340001

    Quem são as pessoas com controle significativo de STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Braveheart Investment Group Plc
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    06/04/2016
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroScotland
    Autoridade legalCompanies Act 2006 Scottish Law
    Local de registroRegister Of Companies Scotland
    Número de registroSc247376
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    STRATHTAY VENTURES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Bond & floating charge
    Criado em 21/03/2001
    Entregue em 09/04/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/04/2001Registro de uma garantia (410)
    • 28/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0