GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC193483
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GLADEDALE (EAST SCOTLAND) LIMITED25/07/200825/07/2008
    GLADEDALE (PARTNERSHIPS) LTD25/01/200725/01/2007
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED26/05/200526/05/2005
    BETT HOMES (NORTH EAST SCOTLAND) LIMITED27/04/200527/04/2005
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED18/03/199918/03/1999
    MITRESHELF 253 LIMITED16/02/199916/02/1999

    Quais são as últimas contas de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2016

    Quais são as últimas submissões para GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2016

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 16/02/2016

    28 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/11/2016

    Estado do capital em 01/11/2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Pedido de restauro administrativo

    3 páginasRT01

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG para Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 16/02/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/03/2015

    Estado do capital em 06/03/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Quem são os diretores de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secretário
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147808920001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie-Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    Secretário
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    British606150011
    BISHOP & ROBERTSON CHALMERS
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secretário nomeado
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    900003620001
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    BAIRD, Ian Coid
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    Diretor
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    ScotlandBritish44063980001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Diretor
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritish79873860001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Diretor
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritish91229410003
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LANG, James Russell
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    Diretor nomeado
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    British900003610001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MACCOLL, Stuart Neil
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    Diretor
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish111800560001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Diretor
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MILLAR, James Allan
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    Diretor nomeado
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    British900003600001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    RIDDLE, Andrew
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    Diretor
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    British117037490001

    Quem são as pessoas com controle significativo de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    06/04/2016
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridade legalUnited Kingdom (Scotland)
    Local de registroCompanies House
    Número de registroSc024489
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 14/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 08/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 28/02/2005
    Entregue em 10/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Land at north-west side of glasgow road, dennyloanhead (title number stg 50880).
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/03/2005Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 21/11/2003
    Entregue em 28/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due pursuant to the personal bond dated 20 may 2003
    Breve descrição
    6.12 acres at greenhill road, bonnybridge, county of stirling.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/11/2003Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 23/05/2003
    Entregue em 30/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    5.98 acres at greenhill road, bonnybridge.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 30/05/2003Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 23/05/2003
    Entregue em 30/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    3.769 hectares at harrysmuir road, houston industrial estate, livingston.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 30/05/2003Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 21/05/2003
    Entregue em 03/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/06/2003Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 28/03/2001
    Entregue em 04/04/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Heritable property at whitehill sidings, whitehill road, hamilton, lanarkshire.
    Pessoas com direito
    • Scottish Homes
    Transações
    • 04/04/2001Registro de uma garantia (410)
    • 04/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0