INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED

INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social
    Número da empresa SC208244
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED19/06/200019/06/2000

    Quais são as últimas contas de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2025
    Próximas contas vencem em30/09/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2024

    Qual é o status da última declaração de confirmação para INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até01/07/2026
    Próxima declaração de confirmação vence15/07/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até01/07/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2024

    13 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/07/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Miss Kathryn Mullaney como diretor em 28/02/2025

    2 páginasAP01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2023

    14 páginasAA

    Nomeação de Mr Graeme Houston Livingstone como diretor em 10/01/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jennifer Mary Mcpartlin como diretor em 06/08/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Lee Macleod como diretor em 02/08/2024

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/07/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Ashley Bisland como diretor em 01/04/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Derek Cooke como diretor em 01/04/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Miss Emma Woolsey como secretário em 02/02/2024

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Ashley Mcclymont Rennie como diretor em 12/03/2024

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Alex Dillon como diretor em 02/04/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Andrew Nugent como diretor em 01/06/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Jennifer Mary Mcpartlin como diretor em 01/02/2023

    2 páginasAP01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2022

    14 páginasAA

    Término da nomeação de Nichola Kane como diretor em 19/03/2024

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Peter Beagley como secretário em 02/02/2024

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Peter Beagley como diretor em 02/02/2024

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/07/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Notificação de Sgs Finco Limited como pessoa com controlo significativo em 22/01/2021

    2 páginasPSC02

    Término da nomeação de Benjamin Aaron Doyle como diretor em 28/06/2023

    1 páginasTM01

    Cessação de Intu Debenture Plc como pessoa com controlo significativo em 22/01/2021

    1 páginasPSC07

    Nomeação de Zunainah Waheed-Saleemi como diretor em 05/01/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jackie Connolly como diretor em 05/01/2023

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WOOLSEY, Emma
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    PO BOX
    Scotland
    Secretário
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    PO BOX
    Scotland
    325138530001
    BISLAND, Ashley
    King's Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    C/O Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Diretor
    King's Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    C/O Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandBritish218181200001
    COOKE, Derek
    Braehead Shopping Centre
    G51 4BS Glasgow
    Primark
    Scotland
    Diretor
    Braehead Shopping Centre
    G51 4BS Glasgow
    Primark
    Scotland
    ScotlandIrish325139110001
    LIVINGSTONE, Graeme Houston
    Braehead Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Boots, Unit 68
    Scotland
    Diretor
    Braehead Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Boots, Unit 68
    Scotland
    ScotlandBritish331673290001
    MACLEOD, Lee
    C/O Braehead Shopping Centre
    King's Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Mcdonald's
    United Kingdom
    Diretor
    C/O Braehead Shopping Centre
    King's Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Mcdonald's
    United Kingdom
    ScotlandScottish325839770001
    MULLANEY, Kathryn
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    M&S Braehead
    United Kingdom
    Diretor
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    M&S Braehead
    United Kingdom
    United KingdomBritish258288770001
    NUGENT, Andrew
    Unit 173 Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G52 4BS Glasgow
    Next Retail
    United Kingdom
    Diretor
    Unit 173 Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G52 4BS Glasgow
    Next Retail
    United Kingdom
    United KingdomBritish323303200001
    THOMPSON, Roisin Sarah Catherine
    Kings Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Lush, Unit 140b, Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Diretor
    Kings Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Lush, Unit 140b, Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandScottish298066830001
    WAHEED-SALEEMI, Zunainah
    Kings Inch Road
    Braehead
    G51 4BN Glasgow
    Unit 61&62
    Scotland
    Diretor
    Kings Inch Road
    Braehead
    G51 4BN Glasgow
    Unit 61&62
    Scotland
    ScotlandBritish,Pakistani311280020001
    WOOLSEY, Emma
    Kings Inch Rd
    G51 4bn
    Renfrew
    Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Diretor
    Kings Inch Rd
    G51 4bn
    Renfrew
    Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandBritish285318380001
    BALDRY, Robert
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Secretário
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    British80553850001
    BEAGLEY, Peter
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Secretário
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    241845010001
    BEAGLEY, Peter
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    Secretário
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    British99608280002
    TURNBULL, Gary
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Intu Braehead
    Scotland
    Secretário
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Intu Braehead
    Scotland
    189461560001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secretário
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    ADAMSON, Craig Howden
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Diretor
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    ScotlandBritish159612680001
    AGNEW, Joyce
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Thomas Cook
    Scotland
    Diretor
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Thomas Cook
    Scotland
    ScotlandBritish199595550001
    ALEXANDER, Gordon
    Silvertonhill Avenue
    ML3 7PF Hamilton
    182
    Lanarkshire
    Diretor
    Silvertonhill Avenue
    ML3 7PF Hamilton
    182
    Lanarkshire
    United KingdomBritish131199160001
    ANDERSON, Paul James
    Inverawe St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    Inverawe St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    British58693300001
    BALDRY, Robert
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Diretor
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    ScotlandBritish80553850001
    BATES, David Gordon
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    105
    West Lothian
    Diretor
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    105
    West Lothian
    ScotlandBritish135074480001
    BEAGLEY, Peter
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Diretor
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    ScotlandBritish99608280002
    BEAGLEY, Peter
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    Diretor
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    ScotlandBritish99608280002
    BERTRAM, Patricia Anne
    Kings Inch Road
    Renfrew
    Unit 12
    United Kingdom
    Diretor
    Kings Inch Road
    Renfrew
    Unit 12
    United Kingdom
    United KingdomBritish212496060002
    BLACKBURN, Sarah
    The Carthouse
    Dykedale
    FK15 0JU Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    The Carthouse
    Dykedale
    FK15 0JU Dunblane
    Perthshire
    British84025350002
    BLOODWORTH, Sarah
    8 Ivybridge Close
    TW1 1EA Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    8 Ivybridge Close
    TW1 1EA Twickenham
    Middlesex
    British83730960001
    BROWN, Mark
    16 Murchison Road
    Crosslee
    PA6 7JU Johnstone
    Renfrewshire
    Diretor
    16 Murchison Road
    Crosslee
    PA6 7JU Johnstone
    Renfrewshire
    British66259720002
    CAMERON, Josephine
    61 Bathgo Avenue
    PA1 3EA Ralston
    Renfrewshire
    Diretor
    61 Bathgo Avenue
    PA1 3EA Ralston
    Renfrewshire
    British116174540001
    CAMPBELL, Malcolm
    Millstream Court
    PA1 1RR Paisley
    88
    Renfrewshire
    Diretor
    Millstream Court
    PA1 1RR Paisley
    88
    Renfrewshire
    British137730180001
    CODMAN, Jonathan
    Ardenconnel Cottage
    Church Road, Rhu
    G84 8RW Helensburgh
    Dunbartonshire
    Diretor
    Ardenconnel Cottage
    Church Road, Rhu
    G84 8RW Helensburgh
    Dunbartonshire
    British77201120001
    CONNOLLY, Jackie
    Intu Braehead
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    H&M
    Scotland
    Diretor
    Intu Braehead
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    H&M
    Scotland
    ScotlandBritish189461610001
    COUGHLIN, Angela
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Diretor
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    United KingdomBritish170717080001
    CRAIG, Pamela
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Thorntons
    United Kingdom
    Diretor
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Thorntons
    United Kingdom
    United KingdomBritish110694310001
    CROALL, Gerardine Veronica
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    Diretor
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    British77201130001
    CROALL, Gerardine Veronica
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    Diretor
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    British77201130001

    Quem são as pessoas com controle significativo de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Churchill Place
    10th Floor
    E14 5HU London
    5
    England
    22/01/2021
    Churchill Place
    10th Floor
    E14 5HU London
    5
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEngland And Wales
    Local de registroCompanies House
    Número de registro08355746
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Intu Debenture Plc
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    England
    04/06/2016
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    England
    Sim
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUk Registrar Of Companies
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House Uk
    Número de registro5890611
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0