SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social
    Número da empresa SC213517
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    • Atividades de trabalho social sem alojamento para idosos e pessoas com deficiência (88100) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SIGHT ACTION15/01/200915/01/2009
    VISUAL IMPAIRMENT SERVICES HIGHLAND06/12/200006/12/2000

    Quais são as últimas contas de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2024
    Próximas contas vencem em31/12/2024
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até03/02/2025
    Próxima declaração de confirmação vence17/02/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até03/02/2024
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Endereço do domicílio registado alterado de Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ Scotland para Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row Aberdeen AB10 1SA em 10/04/2024

    3 páginasAD01

    Ordem judicial numa liquidação (& Anexo da ordem judicial)

    4 páginasWU01(Scot)

    Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Maureen Mary Macmillan como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Rob Polson como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David King como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Emily Elizabeth Mary Gray como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Edward Murray Cochrane como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2023

    23 páginasAA

    Nomeação de Mr Scott Alan Murray como diretor em 21/11/2023

    2 páginasAP01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed sight action\certificate issued on 01/09/23
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name01/09/2023

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Nomeação de Miss Lynsey Daniel como secretário em 01/07/2023

    2 páginasAP03

    Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2022

    26 páginasAA

    Término da nomeação de Sandra May Elizabeth Ross como secretário em 08/11/2022

    1 páginasTM02

    Endereço do domicílio registado alterado de Beechwood House 69 - 71 Old Perth Road Raigmore Inverness Highland Region IV2 3JH para Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ em 15/08/2022

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Edward Murray Cochrane como diretor em 01/02/2022

    2 páginasAP01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2021

    23 páginasAA

    Término da nomeação de Christopher Grant como diretor em 19/08/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Alan Peter Fowler como diretor em 11/05/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Christopher Grant como diretor em 09/03/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2020

    22 páginasAA

    Nomeação de Mr David King como diretor em 10/11/2020

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DANIEL, Lynsey
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Secretário
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    310993760001
    MACLEAN, Angela Margaret
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Diretor
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    ScotlandBritishHighland Councillor93204940001
    MURRAY, Scott Alan
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    Diretor
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    United KingdomBritishCeo173911240003
    ROWANTREE, Robert Ian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Diretor
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    United KingdomBritishLand Manager57180660001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Secretário
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    British57440560001
    MCLENAN, Sarah Louise
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Secretário
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    261749260001
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Secretário
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    BritishSolicitor73180870001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secretário
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    169920830001
    ROSS, Sandra May Elizabeth
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Secretário
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    267631590001
    ROSS, Sandra
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Secretário
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    174219790001
    SPITTAL, Felix Thomas
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secretário
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    164999560001
    BAINBRIDGE, Raymond
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Diretor
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandBritishRitired157900700001
    BOYLE, Nicholas Michael
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    Diretor
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    ScotlandBritishCompany Director116796780001
    CAMPBELL, Hugh Macarthur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritishOptometrist113911180001
    CHATTERTON, Jean, Dr
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired199763500001
    COCHRANE, Edward Murray
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Diretor
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishRetired162624860001
    CULLINGHAM, Terence James
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    Diretor
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    ScotlandBritishRetired97749010002
    CUMMING, Christina
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    BritishHighland Cllr121428950001
    FOWLER, Alan Peter
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritishChief Officer, Signpost258273310001
    FRASER, James Robert Simpson
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritishRetired197996780001
    GRANT, Christopher
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritishCommunity Relationship Officer279588350001
    GRAY, Emily Elizabeth Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Diretor
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishUnemployed218607290003
    HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired183119510001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Diretor
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Scotland,UkBritishHealth Board Manager (Retired)57440560001
    JOHN, David Phillip
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritishRetired166909770001
    KING, David
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Diretor
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director254314190001
    MACDONALD, Margaret
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    Diretor
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    ScotlandBritishNone97901380001
    MACKINNON, Iain
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Diretor
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandScottishPostal Worker179390360001
    MACLEAN, Elizabeth Anne
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    Diretor
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritishRetired27235670001
    MACMILLAN, Maureen Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Diretor
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishRetired26305820003
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishSolicitor73180870001
    MOORE, Raymond John Kentigern
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishRetired90612420001
    PATERSON, David Weatherston
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    Diretor
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    ScotlandBritishRetired150263780001
    POLSON, Rob
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Diretor
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritishLibrarian, Health Sciences, Inverness258273400001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Diretor
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandScottishMinister Of Religion169250390001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    06/12/2016A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    28/03/2024Data da petição
    28/03/2024Início da liquidação
    Liquidação compulsória
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Callum Angus Carmichael
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Profissional
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Graham David Smith
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Profissional
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0