SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Liquidação |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada por garantia sem capital social |
Número da empresa | SC213517 |
Jurisdição | Escócia |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Não |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
- Atividades de trabalho social sem alojamento para idosos e pessoas com deficiência (88100) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row AB10 1SA Aberdeen |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
SIGHT ACTION | 15/01/2009 | 15/01/2009 |
VISUAL IMPAIRMENT SERVICES HIGHLAND | 06/12/2000 | 06/12/2000 |
Quais são as últimas contas de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Vencido | Sim |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/03/2024 |
Próximas contas vencem em | 31/12/2024 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Vencido | Sim |
---|---|
Última declaração de confirmação elaborada até | 03/02/2025 |
Próxima declaração de confirmação vence | 17/02/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 03/02/2024 |
Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereço do domicílio registado alterado de Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ Scotland para Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row Aberdeen AB10 1SA em 10/04/2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Ordem judicial numa liquidação (& Anexo da ordem judicial) | 4 páginas | WU01(Scot) | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Maureen Mary Macmillan como diretor em 31/12/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Rob Polson como diretor em 31/12/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de David King como diretor em 31/12/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Emily Elizabeth Mary Gray como diretor em 31/12/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Edward Murray Cochrane como diretor em 31/12/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2023 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Scott Alan Murray como diretor em 21/11/2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed sight action\certificate issued on 01/09/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Miss Lynsey Daniel como secretário em 01/07/2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2022 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Sandra May Elizabeth Ross como secretário em 08/11/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Beechwood House 69 - 71 Old Perth Road Raigmore Inverness Highland Region IV2 3JH para Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ em 15/08/2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Edward Murray Cochrane como diretor em 01/02/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2021 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Christopher Grant como diretor em 19/08/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alan Peter Fowler como diretor em 11/05/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Christopher Grant como diretor em 09/03/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/02/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2020 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr David King como diretor em 10/11/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL, Lynsey | Secretário | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | 310993760001 | |||||||
MACLEAN, Angela Margaret | Diretor | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | Scotland | British | Highland Councillor | 93204940001 | ||||
MURRAY, Scott Alan | Diretor | Chattan Gardens IV12 4QP Nairn Dunevan Scotland | United Kingdom | British | Ceo | 173911240003 | ||||
ROWANTREE, Robert Ian | Diretor | Union Row AB10 1SA Aberdeen Suite B, 4th Floor, Meridian | United Kingdom | British | Land Manager | 57180660001 | ||||
JACK, Malcolm Lyall | Secretário | Lismore Tower Brae Westhill IV1 2BW Inverness | British | 57440560001 | ||||||
MCLENAN, Sarah Louise | Secretário | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | 261749260001 | |||||||
MERCHANT, Joan Isobel Sinclair | Secretário | 3 Crown Circus IV2 3NH Inverness Inverness Shire | British | Solicitor | 73180870001 | |||||
ROBERTSON, Michael Andrew | Secretário | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | 169920830001 | |||||||
ROSS, Sandra May Elizabeth | Secretário | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | 267631590001 | |||||||
ROSS, Sandra | Secretário | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | 174219790001 | |||||||
SPITTAL, Felix Thomas | Secretário | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | 164999560001 | |||||||
BAINBRIDGE, Raymond | Diretor | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | Scotland | British | Ritired | 157900700001 | ||||
BOYLE, Nicholas Michael | Diretor | Windyhills Achlaschoille Farmhouse Farr IV2 6XG Inverness Invernesshire | Scotland | British | Company Director | 116796780001 | ||||
CAMPBELL, Hugh Macarthur | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | United Kingdom | British | Optometrist | 113911180001 | ||||
CHATTERTON, Jean, Dr | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 199763500001 | ||||
COCHRANE, Edward Murray | Diretor | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Retired | 162624860001 | ||||
CULLINGHAM, Terence James | Diretor | Churchill Drive IV15 9RD Dingwall 11 Ross-Shire | Scotland | British | Retired | 97749010002 | ||||
CUMMING, Christina | Diretor | 72 Kenneth Street IV3 5PZ Inverness Inverness Shire | British | Highland Cllr | 121428950001 | |||||
FOWLER, Alan Peter | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | Scotland | British | Chief Officer, Signpost | 258273310001 | ||||
FRASER, James Robert Simpson | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | United Kingdom | British | Retired | 197996780001 | ||||
GRANT, Christopher | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region | Scotland | British | Community Relationship Officer | 279588350001 | ||||
GRAY, Emily Elizabeth Mary | Diretor | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Unemployed | 218607290003 | ||||
HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 183119510001 | ||||
JACK, Malcolm Lyall | Diretor | Lismore Tower Brae Westhill IV1 2BW Inverness | Scotland,Uk | British | Health Board Manager (Retired) | 57440560001 | ||||
JOHN, David Phillip | Diretor | 69 - 71 Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | British | Retired | 166909770001 | ||||
KING, David | Diretor | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Managing Director | 254314190001 | ||||
MACDONALD, Margaret | Diretor | 13 Balconie Park Evanton IV16 9XD Dingwall Ross Shire | Scotland | British | None | 97901380001 | ||||
MACKINNON, Iain | Diretor | Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Beechwood House Highland Region Scotland | Scotland | Scottish | Postal Worker | 179390360001 | ||||
MACLEAN, Elizabeth Anne | Diretor | Grianan Woodside Avenue PH26 3JR Grantown On Spey Morayshire | Scotland | British | Retired | 27235670001 | ||||
MACMILLAN, Maureen Mary | Diretor | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Retired | 26305820003 | ||||
MERCHANT, Joan Isobel Sinclair | Diretor | 3 Crown Circus IV2 3NH Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Solicitor | 73180870001 | ||||
MOORE, Raymond John Kentigern | Diretor | 8 Abertarff Road IV2 3NW Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Retired | 90612420001 | ||||
PATERSON, David Weatherston | Diretor | Drumnadrochit Drumnadrochit IV63 6TZ Inverness Dalgregaig House United Kingdom | Scotland | British | Retired | 150263780001 | ||||
POLSON, Rob | Diretor | Greenhill Street IV15 9JQ Dingwall Robertson House Scotland | Scotland | British | Librarian, Health Sciences, Inverness | 258273400001 | ||||
ROBERTSON, Michael Andrew | Diretor | 38 Ardconnel Street Inverness IV2 3EX | Scotland | Scottish | Minister Of Religion | 169250390001 |
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED?
Notificado em | Cessado em | Declaração |
---|---|---|
06/12/2016 | A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidação compulsória |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0