MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED

MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC213944
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ANDSTRAT (NO.124) LIMITED19/12/200019/12/2000

    Quais são as últimas contas de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Detalhes do diretor alterados para Mr Neil Fitzsimmons em 01/11/2011

    2 páginasCH01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 21/12/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/02/2012

    Estado do capital em 06/02/2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Approve transfer of property 14/12/2011
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 15/12/2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG02s

    Detalhes do diretor alterados para Norman Yardley em 08/07/2011

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    13 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Share purchase 28/01/2011
    RES13

    Declaração anual preparada até 21/12/2010 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Nomeação de Norman Yardley como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Gaffney como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    13 páginasAA

    Nomeação de Mr Neil Fitzsimmons como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Colin Edward Lewis como diretor

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para David Gaffney em 29/01/2010

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 21/12/2009 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Término da nomeação de Dominic Lavelle como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Robin Johnson como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Joanne Elizabeth Massey como secretário

    2 páginasAP03

    Quem são os diretores de MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808870001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secretário
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secretário
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secretário
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    British67033440002
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    Secretário nomeado
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    900020500001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretário
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secretário nomeado
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Diretor
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottish91209410001
    BROWN, Simon Thomas David
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish118942920001
    CHARITY, Sheena
    18 Long Craig Walk
    KY1 1SJ Kirkcaldy
    Fife
    Diretor
    18 Long Craig Walk
    KY1 1SJ Kirkcaldy
    Fife
    British66765420001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    KERR, John Neilson
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    British65694070001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Diretor
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    British110231420001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    British94163020001
    MACLEOD, Angus Iain
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    Diretor
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    ScotlandBritish57667380001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Diretor
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    British73738070001
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Diretor
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritish176036600001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Diretor
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Diretor
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    British101412420001
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Diretor
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish67033440002
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Diretor
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritish142078700006
    SNEDDON, Lisa Marion
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    Diretor
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    British101413820001

    MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 14/01/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/01/2009Registro de uma garantia (410)
    Floating charge
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 08/01/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/01/2009Registro de uma garantia (410)
    Standard security
    Criado em 13/04/2004
    Entregue em 21/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    37.8 hectares at dollarbeg, dollar CLK8727.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/04/2004Registro de uma garantia (410)
    • 29/03/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 05/04/2004
    Entregue em 16/04/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/04/2004Registro de uma garantia (410)
    Standard security
    Criado em 03/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The additional sum referred to in missives dated 26 june and 23 august 2002
    Breve descrição
    Three areas of ground at dollarbeg, dollar, clackmannanshire (title numbers CLK5768, CLK3368 & CLK7647).
    Pessoas com direito
    • Dollarbeg Estates Limited and Others
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (410)
    • 06/12/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Standard security
    Criado em 05/03/2001
    Entregue em 12/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    494 ferry road, edinburgh.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 12/03/2001Registro de uma garantia (410)
    • 03/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 05/03/2001
    Entregue em 12/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    8 fox covert avenue, edinburgh.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 12/03/2001Registro de uma garantia (410)
    • 03/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 28/02/2001
    Entregue em 02/03/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due under the senior facility agreement dated 28 february 2001
    Breve descrição
    The whole of the property including uncalled capital execept the excepted properties.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/03/2001Registro de uma garantia (410)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0