INCLUSION SCOTLAND

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINCLUSION SCOTLAND
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social, isenção de uso de 'Limited'
    Número da empresa SC243492
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INCLUSION SCOTLAND?

    • Atividades de outras organizações de membros n.e.c. (94990) / Outras atividades de serviços

    Onde fica INCLUSION SCOTLAND?

    Endereço do escritório registrado
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de INCLUSION SCOTLAND?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2025
    Próximas contas vencem em31/12/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2024

    Qual é o status da última declaração de confirmação para INCLUSION SCOTLAND?

    Última declaração de confirmação elaborada até28/03/2026
    Próxima declaração de confirmação vence11/04/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até28/03/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para INCLUSION SCOTLAND?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Nomeação de Mr Alex Julian Nicolas Thelwell como diretor em 01/10/2024

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place Edinburgh EH3 6BB Scotland para 152 Bath Street Glasgow G2 4TB em 01/04/2025

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Ms Amanda Brogan como secretário em 03/02/2025

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Janine Danielle Rennie como diretor em 21/02/2025

    1 páginasTM01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2024

    28 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Nomeação de Mrs Janine Danielle Rennie como diretor em 19/06/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Ms Jennifer Ann Sarafilovic como diretor em 19/06/2024

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Irena Maria Paterson em 23/05/2024

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Dr James Ian Elder-Woodward em 23/05/2024

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Derek Kelter em 23/05/2024

    2 páginasCH01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2023

    27 páginasAA

    Memorando e estatutos

    31 páginasMA

    Declaração de confirmação apresentada em 08/02/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 22-24 Earl Grey Street Edinburgh EH3 9BN Scotland para Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place Edinburgh EH3 6BB em 04/03/2024

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Leo Starrs-Cunningham como diretor em 30/06/2023

    1 páginasTM01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2022

    26 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 08/02/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Leo Starrs-Cunningham em 28/01/2022

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Ryan David Alan Mcmullan como diretor em 28/10/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Kirstein Rummery como diretor em 28/10/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Gillian Lawrence como diretor em 31/05/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Fiona Kumari Campbell como diretor em 28/10/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 08/02/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de INCLUSION SCOTLAND?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BROGAN, Amanda
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Secretário
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    334004570001
    AGRAWAL, Balkishan, Dr
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandBritishRetired161974150001
    DAMS, Kim
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    United KingdomGermanDirector200978190002
    ELDER-WOODWARD, James Ian, Dr
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandBritishRetired126254000002
    KELTER, Derek
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandScottishUnemployed290601630001
    MASON, Andrew David Kean
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandBritishAdvocate265370710001
    PATERSON, Irena Maria
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandBritishRetired156072820001
    SARAFILOVIC, Jennifer Ann
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    ScotlandBritishDiversity, Equality And Inclusion Manager324831240001
    THELWELL, Alex Julian Nicolas
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    Diretor
    Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    152
    Scotland
    United KingdomEnglishSupport Worker334111860001
    CAMPBELL, William Mcarthur
    8 Cochrane Street
    KA12 8PJ Irvine
    Ayrshire
    Secretário
    8 Cochrane Street
    KA12 8PJ Irvine
    Ayrshire
    British63238820001
    LAMB, Joseph William, Dr
    Pentagon Centre
    36-38 Washington Street
    G3 8AZ Glasgow
    Unit 111
    Scotland
    Secretário
    Pentagon Centre
    36-38 Washington Street
    G3 8AZ Glasgow
    Unit 111
    Scotland
    153745800001
    MEYER, Phyl Stuart
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    Secretário
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    280259410001
    SCOTT, William Cameron
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    Secretário
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    174825400001
    WITCHER, Sally Anne, Dr
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    Secretário
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    260937350001
    ARCHIBALD, Susan
    1 Keltyhill Avenue
    KY4 0LH Kelty
    Fife
    Diretor
    1 Keltyhill Avenue
    KY4 0LH Kelty
    Fife
    ScotlandScottishSelf-Employed Speaker125717660001
    BAIRD, Chris David
    Victoria Road
    Barrhead
    G78 1NQ Glasgow
    5
    Scotland
    Diretor
    Victoria Road
    Barrhead
    G78 1NQ Glasgow
    5
    Scotland
    ScotlandBritishRetired163651510001
    BERRINGTON, James Victor
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    Diretor
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishConcierge156115200001
    BIRNEY, Nancy
    690 Mosspark Drive
    G52 3AY Glasgow
    Glasgow Clyde College
    Glasgow
    Scotland
    Diretor
    690 Mosspark Drive
    G52 3AY Glasgow
    Glasgow Clyde College
    Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritishFurther Education133759360001
    BROWN, Alistair
    20 Falmouth Drive
    Arran View
    PA19 1HW Gourock
    Inverclyde
    Diretor
    20 Falmouth Drive
    Arran View
    PA19 1HW Gourock
    Inverclyde
    BritishNone87242130001
    BURKE, Tressa Lynn
    1/1,96 Langside Avenue
    G41 2TR Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Diretor
    1/1,96 Langside Avenue
    G41 2TR Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandScottishDirector Of Charity89220740001
    CAMERON, Colin Alasdair Stewart
    6f Friarscroft
    EH42 1BP Dunbar
    East Lothian
    Diretor
    6f Friarscroft
    EH42 1BP Dunbar
    East Lothian
    ScotlandBritishTrainer/Consultant95428100001
    CAMPBELL, Fiona Kumari, Professor Dr
    Perth Road
    DD1 4HN Dundee
    School Of Education & Social Work, Dundee Uni
    Scotland
    Diretor
    Perth Road
    DD1 4HN Dundee
    School Of Education & Social Work, Dundee Uni
    Scotland
    ScotlandBritish,AustralianProfessor Hei244151120001
    COTTON, Taryn Louise
    Riverbank Court
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2FB Glasgow
    18 Riverbank Court
    United Kingdom
    Diretor
    Riverbank Court
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2FB Glasgow
    18 Riverbank Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone266162470001
    CROCKETT, Christopher
    231 Bearsden Road
    G13 1DH Glasgow
    Diretor
    231 Bearsden Road
    G13 1DH Glasgow
    ScotlandAmericanUnemployed95428080001
    DUNCAN, Pamela
    Pentagon Centre
    36-38 Washington Street
    G3 8AZ Glasgow
    Unit 111
    Scotland
    Diretor
    Pentagon Centre
    36-38 Washington Street
    G3 8AZ Glasgow
    Unit 111
    Scotland
    ScotlandBritishPolicy Officer149569870001
    DURIE, Margaret
    33 Duddingston View
    EH15 3LZ Edinburgh
    Diretor
    33 Duddingston View
    EH15 3LZ Edinburgh
    United KingdomBritishCoordinator95428050001
    ELDER WOODWARD, James
    Rosshead Coachhouse
    Heather Avenue
    G83 0TJ Alexandria
    Dunbartonshire
    Diretor
    Rosshead Coachhouse
    Heather Avenue
    G83 0TJ Alexandria
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishRetired68801540001
    FRIEL, Tom
    15 Valleyfield
    Milton Of Campsie
    G66 8HN Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    15 Valleyfield
    Milton Of Campsie
    G66 8HN Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector117685820001
    GARLAND, Elizabeth Carson
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    Diretor
    23 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Hayweight House
    Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishRetired105117670001
    KELTER, Derek
    62 Milton Street
    ML1 1DQ Motherwell
    Lanarkshire
    Diretor
    62 Milton Street
    ML1 1DQ Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishProject Co Ordinator109231430001
    LAMB, Joseph William, Dr
    5 Clatto Place
    KY16 8SD St Andrews
    Fife
    Diretor
    5 Clatto Place
    KY16 8SD St Andrews
    Fife
    ScotlandBritishScientist61774030001
    LAWRENCE, Gillian
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    Diretor
    Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    22-24
    Scotland
    ScotlandBritishCivil Servant248341970001
    MACKAY, Morag
    62 Newton Avenue
    Cambuslang
    G72 7RT Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    62 Newton Avenue
    Cambuslang
    G72 7RT Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishSelf Employed-Trainer/Consulta87242120001
    MACKINTOSH, Michael Greaves
    Ashyards Court
    Eaglesfield
    DG11 3PE Lockerbie
    10
    United Kingdom
    Diretor
    Ashyards Court
    Eaglesfield
    DG11 3PE Lockerbie
    10
    United Kingdom
    ScotlandBritishNone265371050001
    MACLEOD, James
    Corran Bungalow
    Fyfe Park Road
    PA14 6RL Port Glasgow
    Renfrewshire
    Diretor
    Corran Bungalow
    Fyfe Park Road
    PA14 6RL Port Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandScottishNone89093600002

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para INCLUSION SCOTLAND?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    06/02/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0