GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC244049 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
- fabricação de outras obras de carpintaria e marcenaria para construção (16230) / Indústrias transformadoras
Onde fica GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MK TIMBER SYSTEMS LIMITED | 04/09/2008 | 04/09/2008 |
| EUROPEAN TIMBER SYSTEMS LIMITED | 04/02/2004 | 04/02/2004 |
| TIMBER KIT & TREATMENT WAREHOUSE LIMITED | 17/02/2003 | 17/02/2003 |
Quais são as últimas contas de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Estado do capital em 22/12/2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 16/12/2015
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG para Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT em 23/10/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia SC2440490005 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia SC2440490006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 17/02/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registo da garantia SC2440490005, criada em 12/02/2015 | 19 páginas | MR01 | ||||||||||
Registo da garantia SC2440490006, criada em 12/02/2015 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Quem são os diretores de GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretário | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147808830001 | |||||||
| LEWIS, Colin Edward | Diretor | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Diretor | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| BERRY, Catherine | Secretário | 2 Avonhead Avenue Cumbernauld G67 4RB Lanarkshire | British | 66060190004 | ||||||
| BERRY, Catherine | Secretário | 2 Avonhead Avenue Cumbernauld G67 4RB Lanarkshire | British | 66060190004 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Secretário | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretário | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Secretário | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| ACS SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 19 Glasgow Road PA1 3QX Paisley Renfrewshire | 900019760001 | |||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Diretor | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| DIPRE, Remo | Diretor | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DIPRE, Remo | Diretor | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Diretor | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Diretor | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Diretor | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| HECHT, Walter | Diretor | Braehead House 20 Braehead Road, Thorntonhall G74 5AQ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 94332950001 | |||||
| HOLMES, David Scott | Diretor | Arnotdene Arnothill Lane FK1 5SL Falkirk | Scotland | British | 102000001 | |||||
| INGRAM, David Colin | Diretor | Bridleways Woodcote Green Road KT18 7DN Epsom Surrey | British | 109149390001 | ||||||
| KEENAN, Grant Patrick | Diretor | 36 South Broomage Avenue FK5 3ED Larbert Stirlingshire | Scotland | British | 111271350001 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Diretor | Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow 35 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Diretor | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCKINNON, Craig William | Diretor | 53 Newtonlea Avenue Newton Mearns G77 5QF Glasgow | Scotland | British | 14490650002 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Diretor | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Diretor | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| RATHBONE, Kevin | Diretor | 4 St Mungos View EH26 8JA Penicuik Midlothian | British | 13920001 | ||||||
| SCOTT, David | Diretor | 66 Castle Street TD11 3BE Duns Berwickshire | British | 127153850001 | ||||||
| ACS NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | 19 Glasgow Road PA1 3QX Paisley Renfrewshire | 900019750001 |
GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 12/02/2015 Entregue em 19/02/2015 | Totalmente satisfeita | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 12/02/2015 Entregue em 19/02/2015 | Totalmente satisfeita | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 30/12/2008 Entregue em 14/01/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 30/12/2008 Entregue em 08/01/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 22/07/2005 Entregue em 30/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 05/07/2004 Entregue em 15/07/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0