SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC245928 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LOTHIAN FIFTY (978) LIMITED | 18/03/2003 | 18/03/2003 |
Quais são as últimas contas de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 5 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Joseph Mark Linney em 24/07/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Christopher James Tanner em 24/07/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/03/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2018 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr William Spurr em 19/03/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Shanks Pfi Investments Limited como pessoa com controlo significativo em 09/10/2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nomeação de Mr William Spurr como diretor em 23/01/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Alfred Cowan como diretor em 22/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2017 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/03/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2016 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Joanna Griffiths como diretor em 29/07/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alistair Daniel Brookes como diretor em 27/07/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Alfred Cowan como diretor em 28/07/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/03/2016 com lista completa de acionistas | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Robert Ian Cartwright como diretor em 25/02/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Adam Nathaniel Richford como diretor em 25/02/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Alistair Daniel Brookes como diretor em 01/01/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard | Secretário | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | British | 130189950001 | ||||||
| LINNEY, Joseph Mark | Diretor | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London England | Scotland | British | 63161960001 | |||||
| RICHFORD, Adam Nathaniel | Diretor | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 126705600001 | |||||
| SPURR, William | Diretor | c/o Mr Philip Griffin-Smith Renewi Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 126011000001 | |||||
| TANNER, Christopher James | Diretor | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London | England | British | 134603140001 | |||||
| GIBSON, Carolyn Ann | Secretário | Polo Barn Nairdwood Lane HP16 0QH Great Missenden Buckinghamshire | British | 119043460001 | ||||||
| KAYE, Paul | Secretário | Old Market Place Market Lane Greet GL54 5BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 3245340002 | ||||||
| BURNESS | Secretário nomeado | 242 West George Street G2 4QY Glasgow | 900020360001 | |||||||
| BURNESS LLP | Secretário | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| AITCHISON, Nigel Ian | Diretor | Willow House 29 High Street Silverstone NN12 8US Towcester Northamptonshire | England | British | 88285320001 | |||||
| AVERILL, Michael Charles Edward | Diretor | Little Meadow Upton Road Dinton HP17 8UQ Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24913560002 | |||||
| BROOKES, Alistair Daniel | Diretor | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 196460830001 | |||||
| CARTWRIGHT, Robert Ian | Diretor | c/o Phil Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 73331440001 | |||||
| CLARKE, Michael James | Diretor | Derwen House Kibblestone Road ST15 8UJ Stone Staffordshire | England | British | 154591790014 | |||||
| COWAN, Mark Alfred | Diretor | c/o C/O Mr Philip Griffin-Smith Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | Scotland | British | 211107930001 | |||||
| DOWNES, David John | Diretor | Holden Brook New Barn Lane RH5 5PF Ockley Surrey | United Kingdom | British | 37289200002 | |||||
| EGLINTON, Peter Damian | Diretor | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | United Kingdom | British | 137660810001 | |||||
| GOODFELLOW, Ian Frederick | Diretor | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 28725450004 | |||||
| GRIFFITHS, Joanna | Diretor | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 176450190001 | |||||
| HARDY, David Michael | Diretor | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | England | British | 106339430006 | |||||
| HARMER, Andrew Keith | Diretor | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 129905330002 | |||||
| MCVICKER, Alan William Fullerton | Diretor | Ballykeel East Tulchan Steadings PH1 3SG Glenalmond Perthshire | British | 142373580001 | ||||||
| MULLIGAN, David Kevin | Diretor | c/o Mr Philip Griffin-Smith Shanks Group Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 74215210003 | |||||
| PEARSON, Andrew Stephen | Diretor | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 91780000001 | |||||
| RAY, Stephen Leslie | Diretor | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 169241640001 | |||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Diretor | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 139588670003 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Diretor | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162166120001 | |||||
| STOCKLEY, Darren | Diretor | 52 Paddock Gardens SO41 9ES Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 61712020003 | |||||
| SURCH, Christopher | Diretor | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138144350001 | |||||
| TRANTER, Julian Ashley | Diretor | Auckland Park, Mount Farm Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House United Kingdom | United Kingdom | British | 148676690001 | |||||
| WAPLES, Christopher Brian | Diretor | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 41387640003 | |||||
| WELHAM, Fraser Andrew Norton | Diretor | Pennard Terry Road HP13 6QJ High Wycombe Buckinghamshire | Uk | British | 105268510002 | |||||
| BURNESS (DIRECTORS) LIMITED | Diretor nomeado | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900019120001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Laing Environmental Assets Group (Uk) Limited | 06/04/2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Renewi Pfi Investments Limited | 06/04/2016 | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Criado em 25/11/2004 Entregue em 16/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The right,title and interest in and to the assigned agreements, the security guarantees and all of the proceeds thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 25/11/2004 Entregue em 09/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0