TAYDALE (GRANTON) LIMITED

TAYDALE (GRANTON) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTAYDALE (GRANTON) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC258109
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    • construção de edifícios comerciais (41201) / Construção

    Onde fica TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MITRESHELF 353 LIMITED23/10/200323/10/2003

    Quais são as últimas contas de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/11/2016 com atualizações

    7 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 10

    5 páginasMR04

    Estado do capital em 07/07/2016

    • Capital: GBP 2.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Detalhes do diretor alterados para Keith Richard Douglas em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG para Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 23/10/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/10/2015

    Estado do capital em 23/10/2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    14 páginasAA

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    4 páginasMR04

    Quem são os diretores de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secretário
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    British150144100001
    DOUGLAS, Keith Richard
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish91229410003
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    Secretário
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    British175715660001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secretário
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DE FEO, Caterina
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    Secretário
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    British58246930001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secretário
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secretário
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    BISHOPS
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secretário nomeado
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    900025710001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretário
    St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registroSO300744
    119967690001
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    ARMSTRONG, Karen Jean
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Diretor
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    United KingdomBritish137938400001
    BROWN, Simon Christopher
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Diretor
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    United KingdomBritish113724050001
    BURNS, William Rae
    Barnton Grove
    Barnton
    EH4 6EJ Edinburgh
    24
    Diretor
    Barnton Grove
    Barnton
    EH4 6EJ Edinburgh
    24
    United KingdomBritish132773610001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COPSTICK, Thomas Crawford
    B Glasgow Road
    Ralston
    PA1 3JR Paisley
    227
    Renfrewshire
    Scotland
    Diretor
    B Glasgow Road
    Ralston
    PA1 3JR Paisley
    227
    Renfrewshire
    Scotland
    British129081370001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FOWLER, Steven
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    Diretor
    Glasgow Airport Business Park
    Marchburn Drive
    PA3 2SJ Abbotsinch
    Unit C, Ground Floor, Cirrus
    Paisley
    United KingdomBritish101839920001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    Diretor
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    ScotlandBritish84605410002
    HALDANE, Kenneth Douglas
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    Diretor
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    United KingdomBritish94477860001
    KENNEDY, David Samuel
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    Diretor
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    British93176930001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    Diretor
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    United KingdomBritish102797820001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102797820001
    KNIGHT, David Jonathan
    24 Margaret Rose Crescent
    EH10 7EZ Edinburgh
    Diretor
    24 Margaret Rose Crescent
    EH10 7EZ Edinburgh
    United KingdomBritish190746580001
    MACLEOD, Angus Iain
    St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Diretor
    St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    ScotlandBritish57667380001
    MACLEOD, Joanne May
    Silvermills
    EH3 5BF Edinburgh
    23/3
    Diretor
    Silvermills
    EH3 5BF Edinburgh
    23/3
    British118869790002
    MCGOWAN, Jim
    66 Mulben Crescent
    G53 7EH Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    66 Mulben Crescent
    G53 7EH Glasgow
    Lanarkshire
    British123746950001
    MITCHELL, David Murray
    9 Kirklands Drive
    Newton Mearns
    G77 5FF Glasgow
    Diretor
    9 Kirklands Drive
    Newton Mearns
    G77 5FF Glasgow
    British91206920001
    MORAN, Paul Anthony
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish96935230001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    Diretor
    Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Regency House
    Fife
    United KingdomBritish207729000002
    PHILLIPS, Richard James
    5 Brighouse Park Court
    Cramond
    EH4 6QF Edinburgh
    Diretor
    5 Brighouse Park Court
    Cramond
    EH4 6QF Edinburgh
    British118057520001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    MITRESHELF DIRECTORS LIMITED
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Diretor nomeado
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    900025700001

    Quem são as pessoas com controle significativo de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    06/04/2016
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro9304211
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    TAYDALE (GRANTON) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Standard security
    Criado em 02/02/2010
    Entregue em 15/02/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Obligations contained in the missives
    Breve descrição
    Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170.
    Pessoas com direito
    • Forth Property Developments Limited
    Transações
    • 15/02/2010Registro de uma garantia (MG01s)
    • 01/10/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 02/02/2010
    Entregue em 13/02/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 13/02/2010Registro de uma garantia (MG01s)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of accession to residential security agreement
    Criado em 29/01/2010
    Entregue em 05/02/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property owned by it, all plant and machinery etc-see form for further details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/02/2010Registro de uma garantia (MG01s)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 29/01/2010
    Entregue em 05/02/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/02/2010Registro de uma garantia (MG01s)
    • 05/02/2010Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 17/02/2010Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Standard security
    Criado em 09/02/2004
    Entregue em 19/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Plots 26 & 27 granton harbour, edinburgh MID56170.
    Pessoas com direito
    • Taylor Woodrow Developments Limited
    Transações
    • 19/02/2004Registro de uma garantia (410)
    • 04/11/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 09/02/2004
    Entregue em 19/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Plots 26 & 27 at granton harbour, edinburgh MID56170.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/02/2004Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 09/02/2004
    Entregue em 17/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Part of two areas of ground forming plots 26 & 27, granton harbour, edinburgh.
    Pessoas com direito
    • Forth Property Developments Limited
    Transações
    • 17/02/2004Registro de uma garantia (410)
    • 04/11/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 09/02/2004
    Entregue em 12/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Obligations set out in the missives
    Breve descrição
    Plots 26 & 27 granton harbpur, edinburgh.
    Pessoas com direito
    • Forth Property Developments Limited
    Transações
    • 12/02/2004Registro de uma garantia (410)
    • 04/11/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 23/01/2004
    Entregue em 29/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Taylor Woodrow Developments Limited
    Transações
    • 29/01/2004Registro de uma garantia (410)
    • 03/02/2004Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/03/2006Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 10/02/2010Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 23/01/2004
    Entregue em 29/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/01/2004Registro de uma garantia (410)
    • 03/02/2004Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 28/01/2005Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 08/03/2006Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 05/02/2010Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 17/02/2010Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0