TAYDALE (GRANTON) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | TAYDALE (GRANTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC258109 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
- construção de edifícios comerciais (41201) / Construção
Onde fica TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MITRESHELF 353 LIMITED | 23/10/2003 | 23/10/2003 |
Quais são as últimas contas de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2014 |
Quais são as últimas submissões para TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 02/11/2016 com atualizações | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 10 | 5 páginas | MR04 | ||||||||||
Estado do capital em 07/07/2016
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Keith Richard Douglas em 22/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG para Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT em 23/10/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 23/10/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Quem são os diretores de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretário | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | British | 150144100001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Diretor | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||||||
| LEWIS, Colin Edward | Diretor | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||||||
| SHARP, Giles Henry | Diretor | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretário | New Bond Street W1S 1SB London 80 United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretário | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||||||
| DE FEO, Caterina | Secretário | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secretário | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||||||
| JORDAN, James John | Secretário | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||||||
| BISHOPS | Secretário nomeado | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025710001 | |||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretário | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 |
| 119967690001 | ||||||||||
| ANDERSON, Alexander | Diretor | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||||||
| ARMSTRONG, Karen Jean | Diretor | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 137938400001 | |||||||||
| BROWN, Simon Christopher | Diretor | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 113724050001 | |||||||||
| BURNS, William Rae | Diretor | Barnton Grove Barnton EH4 6EJ Edinburgh 24 | United Kingdom | British | 132773610001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Diretor | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||||||
| COPSTICK, Thomas Crawford | Diretor | B Glasgow Road Ralston PA1 3JR Paisley 227 Renfrewshire Scotland | British | 129081370001 | ||||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Diretor | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||||||
| FOWLER, Steven | Diretor | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 101839920001 | |||||||||
| GAFFNEY, David | Diretor | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | Scotland | British | 84605410002 | |||||||||
| HALDANE, Kenneth Douglas | Diretor | 64 Victoria Road PA2 9PT Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 94477860001 | |||||||||
| KENNEDY, David Samuel | Diretor | 1 Glebe Gardens EH12 7SG Edinburgh | British | 93176930001 | ||||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Diretor | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Diretor | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KNIGHT, David Jonathan | Diretor | 24 Margaret Rose Crescent EH10 7EZ Edinburgh | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Diretor | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | Scotland | British | 57667380001 | |||||||||
| MACLEOD, Joanne May | Diretor | Silvermills EH3 5BF Edinburgh 23/3 | British | 118869790002 | ||||||||||
| MCGOWAN, Jim | Diretor | 66 Mulben Crescent G53 7EH Glasgow Lanarkshire | British | 123746950001 | ||||||||||
| MITCHELL, David Murray | Diretor | 9 Kirklands Drive Newton Mearns G77 5FF Glasgow | British | 91206920001 | ||||||||||
| MORAN, Paul Anthony | Diretor | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 96935230001 | |||||||||
| MORTIMORE, Jon William | Diretor | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||||||
| PHILLIPS, Richard James | Diretor | 5 Brighouse Park Court Cramond EH4 6QF Edinburgh | British | 118057520001 | ||||||||||
| YARDLEY, Norman | Diretor | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||||||
| MITRESHELF DIRECTORS LIMITED | Diretor nomeado | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025700001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes Group Limited | 06/04/2016 | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
TAYDALE (GRANTON) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Criado em 02/02/2010 Entregue em 15/02/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Obligations contained in the missives | |
Breve descrição Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 02/02/2010 Entregue em 13/02/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of accession to residential security agreement | Criado em 29/01/2010 Entregue em 05/02/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property owned by it, all plant and machinery etc-see form for further details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 29/01/2010 Entregue em 05/02/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 09/02/2004 Entregue em 19/02/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Plots 26 & 27 granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 09/02/2004 Entregue em 19/02/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Plots 26 & 27 at granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 09/02/2004 Entregue em 17/02/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Part of two areas of ground forming plots 26 & 27, granton harbour, edinburgh. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 09/02/2004 Entregue em 12/02/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Obligations set out in the missives | |
Breve descrição Plots 26 & 27 granton harbpur, edinburgh. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 23/01/2004 Entregue em 29/01/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Floating charge | Criado em 23/01/2004 Entregue em 29/01/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0