ALEXANDRA PARK LIMITED

ALEXANDRA PARK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaALEXANDRA PARK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC290789
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ALEXANDRA PARK LIMITED?

    • (8514) /

    Onde fica ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RESONANZ LIMITED23/09/200523/09/2005

    Quais são as últimas contas de ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Qual é o status da última declaração anual para ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB Uk para C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House Rutland Square Edinburgh EH1 2AA em 12/05/2015

    2 páginasAD01

    Término da nomeação de David Charles Lovett como diretor em 05/05/2015

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB United Kingdom para 1206 Tollcross Road Glasgow Scotland G32 8HH em 03/11/2014

    2 páginasAD01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of a change to the Registered Office have been removed as this was invalid or ineffective.

    Término da nomeação de Stephen Jonathan Taylor como diretor em 31/12/9999

    3 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s termination of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Término da nomeação de David Charles Lovett como diretor em 31/10/2014

    3 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s termination of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomeação de Jeffrey Simpson como secretário em 01/11/2014

    4 páginasAP03
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the secretary’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomeação de Elizabeth Madden como diretor em 01/11/2014

    AP01

    Nomeação de Mr William Madden como diretor em 01/11/2014

    4 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomeação de Maureen Elizabeth Appleyard como diretor em 01/11/2014

    AP01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomeação de Dr James Paton Murray como diretor em 01/11/2014

    4 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    18/03/2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.
    18/03/2015Clarification Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    legacy

    2 páginasAC93

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Mccormack como secretário

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Timothy Bolot como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Charles Lovett como diretor

    2 páginasAP01

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4(Scot)

    Aviso do relatório da reunião que aprova o acordo voluntário com os credores

    4 páginas1.1(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de , C/O Southern Cross Healthcare, the Castle Business Park Lomond Court, Ground Floor Unit 2, Stirling, Scotland, FK9 4TU para C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB em 20/01/2012

    1 páginasAD01

    legacy

    5 páginasMG04s

    Quem são os diretores de ALEXANDRA PARK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Diretor
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    United KingdomBritishDirector163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secretário
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304660001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secretário
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    BritishSecretary168970640001
    PARK, Neil
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    British95141670001
    PARK, Neil
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    British95141670001
    J.M.SIMPSON & CO
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    76324870001
    J.M.SIMPSON & CO
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    76324870001
    APPLEYARD, Maureen Elizabeth
    4 Craigmyle Gardens
    TD1 3LP Clovenfords
    Selkirkshire
    Diretor
    4 Craigmyle Gardens
    TD1 3LP Clovenfords
    Selkirkshire
    UkBritishRetired192316800001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Diretor
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    DONOGHUE, Alan Bell
    51 Egilsay Street
    G22 7RQ Glasgow
    Diretor
    51 Egilsay Street
    G22 7RQ Glasgow
    BritishDirector112734150001
    DONOHOE, Brian Harold
    5 Greenfield Drive
    KA12 0ED Irvine
    Ayreshire
    Diretor
    5 Greenfield Drive
    KA12 0ED Irvine
    Ayreshire
    ScotlandBritishMember Of Parliament242888340002
    FOULKES, Kamma
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    Diretor
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector111188390002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Diretor
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritishDirector34419700002
    MADDEN, Elizabeth
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    Diretor
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    ScotlandBritishDirector88192670001
    MADDEN, William
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    Diretor
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    ScotlandBritishDirector88192640001
    MIDMER, Richard Neil
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Diretor
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritishDirector110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Diretor
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    MURRAY, James Paton, Dr
    Craigmyle Gardens
    Craigmyle Park
    TD1 3LP Clovenfords
    4
    Scottish Borders
    Uk
    Diretor
    Craigmyle Gardens
    Craigmyle Park
    TD1 3LP Clovenfords
    4
    Scottish Borders
    Uk
    United KingdomBritishDirector48415950003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Diretor
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    Diretor
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector147997950001

    ALEXANDRA PARK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental legal mortgage
    Criado em 06/05/2011
    Entregue em 20/05/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Alexandra park alexandra way newbiggin-by-the sea ND157495.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/05/2011Registro de uma garantia (MG01s)
    • 17/11/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Supplemental legal mortgage
    Criado em 25/09/2009
    Entregue em 07/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Alexandra park alexandra way newbiggin-by-the-sea northumberland ND157495.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/10/2009Registro de uma garantia (MG01s)
    • 17/11/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Deed of accession and charge
    Criado em 16/01/2009
    Entregue em 29/01/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 17/11/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04s)
    Legal charge
    Criado em 11/08/2006
    Entregue em 16/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over land to north east of hazlewood avenue , known as the demolition field, newbiggin-by-the-sea.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/08/2006Registro de uma garantia (410)
    • 18/07/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 05/07/2006
    Entregue em 08/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/07/2006Registro de uma garantia (410)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    ALEXANDRA PARK LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0