GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED

GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC292695
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WEST COAST CAPITAL (HORTIS) LIMITED27/02/200627/02/2006
    PACIFIC SHELF 1351 LIMITED03/11/200503/11/2005

    Quais são as últimas contas de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/12/2018

    Quais são as últimas submissões para GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Conta final antes da dissolução em MVL (conta final anexa)

    7 páginasLIQ13(Scot)

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 28/05/2020

    LRESSP

    Término da nomeação de Laura Harradine-Greene como secretário em 07/05/2020

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 30/12/2018

    27 páginasAA

    Término da nomeação de Justin Matthew King como diretor em 04/03/2020

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 13 Queen's Road Aberdeen AB15 4YL para C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH em 17/12/2019

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Anthony Gerald Jones como diretor em 06/12/2019

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 06/11/2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of the share premium account 30/10/2019
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 29/10/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Satisfação total da garantia SC2926950010

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC2926950012

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC2926950009

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC2926950011

    4 páginasMR04

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    29 páginasAA

    Nomeação de Mr Richard Maclachlan como diretor em 01/02/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Roger Mclaughlan como diretor em 01/02/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Justin Matthew King como diretor em 01/11/2018

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 29/10/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Laura Harradine-Greene como secretário em 01/02/2018

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Mary Elizabeth Bourlet como secretário em 01/02/2018

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 03/11/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Quem são os diretores de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MACLACHLAN, Richard John
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Diretor
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    EnglandBritish255019700001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    Secretário
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    213121340002
    HAMILTON, Kirsty Elizabeth
    23 Speyburn Place
    Lawthorn
    KA11 2BE Irvine
    Ayrshire
    Secretário
    23 Speyburn Place
    Lawthorn
    KA11 2BE Irvine
    Ayrshire
    British127615890001
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Secretário
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    242726430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Secretário
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    British72128340003
    SEALES, Sharon
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    Secretário
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    British106673560001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Secretário
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    173148570001
    WARD, Elizabeth Ann
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Secretário
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    205482880001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secretário nomeado
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish124019940001
    DAVIDSON, Paul Richmond
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    Diretor
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    United KingdomBritish114537830001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Diretor
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Diretor
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Diretor
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish72128340003
    JONES, Anthony Gerald
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish212265950002
    KING, Justin Matthew
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Diretor
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    EnglandBritish254876200001
    KING, Justin Matthew
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    Diretor
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LESLAU, Nicholas Mark
    48a Upper Brook Street
    W1K 2BT London
    Diretor
    48a Upper Brook Street
    W1K 2BT London
    United KingdomBritish6815470015
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Diretor
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritish1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish208653010001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Diretor
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    EnglandBritish162853840001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Diretor
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    PITCHER, Stephen John
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    United KingdomBritish138172490001
    ROBERTSON, Lorraine Anne
    St. Leonards Forest
    RH13 6PH Horsham
    Boundary Cottage
    West Sussex
    Diretor
    St. Leonards Forest
    RH13 6PH Horsham
    Boundary Cottage
    West Sussex
    EnglandBritish138172640001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Diretor
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United KingdomGerman126422100002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Diretor nomeado
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Quem são as pessoas com controle significativo de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Garden Centre Group Limited
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    06/04/2016
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroScotland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House Scotland
    Número de registroSc324083
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 20/09/2017
    Entregue em 02/10/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture.
    Devedor atuando como fiduciário nu: Sim
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transações
    • 02/10/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 30/07/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 20/09/2017
    Entregue em 29/09/2017
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transações
    • 29/09/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 30/07/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 20/09/2017
    Entregue em 27/09/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 27/09/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 30/07/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 20/09/2017
    Entregue em 26/09/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    None.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 26/09/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 30/07/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security accession deed
    Criado em 24/04/2012
    Entregue em 03/05/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 03/05/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 17/10/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 24/04/2012
    Entregue em 03/05/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 03/05/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 17/10/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 24/02/2009
    Entregue em 04/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/03/2009Registro de uma garantia (410)
    • 11/03/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 24/02/2009
    Entregue em 04/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/03/2009Registro de uma garantia (410)
    • 11/03/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Supplemental charge
    Criado em 12/02/2007
    Entregue em 01/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The supplemental chargor with full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, has assigned, in favour of the security agent all its rights title and interest in and to the loan agreement and the borrower security documents.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 01/03/2007Registro de uma garantia (410)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Floating charge
    Criado em 20/04/2006
    Entregue em 04/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed charges over land and other assets (see paper apart 2 for details)including assignment and floating charge.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/05/2006Registro de uma garantia (410)
    • 13/03/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 20/04/2006
    Entregue em 04/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/05/2006Registro de uma garantia (410)
    • 13/03/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 27/02/2006
    Entregue em 08/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 08/03/2006Registro de uma garantia (410)
    • 03/05/2012Declaração de satisfação de um encargo flutuante (MG03s)

    GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    2
    DataTipo
    09/02/2021Data prevista de dissolução
    28/05/2020Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0