TURNDEBTAROUND LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTURNDEBTAROUND LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC296390
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TURNDEBTAROUND LTD?

    • Intermediação financeira n.c.o.p. (64999) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica TURNDEBTAROUND LTD?

    Endereço do escritório registrado
    8 Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TURNDEBTAROUND LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NEWTOMORROW LIMITED31/01/200631/01/2006

    Quais são as últimas contas de TURNDEBTAROUND LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2019

    Quais são as últimas submissões para TURNDEBTAROUND LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2019

    11 páginasAA

    Término da nomeação de Daniel Thomas Slater Walker como diretor em 09/07/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 4 Queen Street Suite 1 Edinburgh EH2 1JE Scotland para 8 Albany Street Hudson House Business Centre Edinburgh EH1 3QB em 08/02/2019

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2018

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Notificação de Porterfield Financial Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 12/12/2017

    2 páginasPSC02

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2017

    10 páginasAA

    legacy

    2 páginasGUARANTEE2

    Satisfação total da garantia SC2963900003

    1 páginasMR04

    Registo da garantia SC2963900004, criada em 05/12/2017

    15 páginasMR01

    Satisfação total da garantia SC2963900002

    1 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de Gf - 6 Deer Park Avenue Fairways Business Park Livingston West Lothian EH54 8AF Scotland para 4 Queen Street Suite 1 Edinburgh EH2 1JE em 16/10/2017

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr David Andrew Gray como diretor em 11/09/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Morton Fraser Secretaries Limited como secretário em 22/09/2017

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Thomas Martin Jones como diretor em 11/08/2017

    2 páginasAP01

    Cessação de Invocas Group Plc como pessoa com controlo significativo em 11/08/2017

    1 páginasPSC07

    Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Término da nomeação de David Ewing como diretor em 31/01/2017

    1 páginasTM01

    Nomeação de Morton Fraser Secretaries Limited como secretário em 09/12/2016

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Julie-Anne Afrin como diretor em 09/12/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Julie-Anne Afrin como secretário em 09/12/2016

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de TURNDEBTAROUND LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GRAY, David Andrew
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Diretor
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    United KingdomBritish156334330001
    JONES, Thomas Martin
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Diretor
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    EnglandBritish137147240002
    AFRIN, Julie-Anne
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Secretário
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    178000700001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Secretário
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    British136151950001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Secretário
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    British167366960001
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Secretário
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British47296680002
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Secretário
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    British169956040001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secretário nomeado
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Secretário
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registroSC262093
    95512800001
    AFRIN, Julie-Anne
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Diretor
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish132606040001
    BELL, Howard James
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    Diretor
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    British8909130003
    CARTWRIGHT, Bentley Norman
    Waterloo Bank
    EH26 8NS Penicuik
    16
    Midlothian
    Diretor
    Waterloo Bank
    EH26 8NS Penicuik
    16
    Midlothian
    United KingdomBritish129918710001
    DINOLFI, Amerigo
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Diretor
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish105243090001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Diretor
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    ScotlandBritish136151950001
    EWING, David
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Diretor
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish86695980003
    FERGUSON, Brian
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Diretor
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish154774310001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Diretor
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish107926760002
    HALL, John Michael
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107926760002
    LEWIS, Peter Cyril Robert
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    Diretor
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    EnglandBritish56467830001
    LIGHTLEY, Stephen John
    Graham Park Road
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    36
    England
    Diretor
    Graham Park Road
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    36
    England
    United KingdomBritish47296680002
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Diretor
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish47296680002
    MACMILLAN, David Roy
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    Diretor
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    ScotlandBritish175002230001
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Diretor
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish67033440002
    REYNOLDS, Caroline Michelle
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Diretor
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176061270001
    WALKER, Daniel Thomas Slater
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Diretor
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    EnglandBritish159962640001
    WRIGHT, Ian William
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    Diretor
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish111353760002
    WRIGHT, Rachel Jane Simpson
    Kirklee Circus
    Kelvinside
    G12 0TW Glasgow
    5
    Diretor
    Kirklee Circus
    Kelvinside
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish129920750001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Diretor nomeado
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Quem são as pessoas com controle significativo de TURNDEBTAROUND LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    West Dock Street
    HU3 4HH Hull
    West 1 Business Centre
    England
    12/12/2017
    West Dock Street
    HU3 4HH Hull
    West 1 Business Centre
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro10902667
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    Invocas Group Plc
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6
    Scotland
    14/01/2017
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6
    Scotland
    Sim
    Forma jurídicaPlc
    País de registroScotland
    Autoridade legalCompanies Act 2006 Uk
    Local de registroScotland
    Número de registroSc295886
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    TURNDEBTAROUND LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 05/12/2017
    Entregue em 08/12/2017
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Kpi (Nominees) Limited
    Transações
    • 08/12/2017Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 26/05/2016
    Entregue em 07/06/2016
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Kpi (Nominees) Limited
    Transações
    • 07/06/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 07/06/2016Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 30/12/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    A registered charge
    Criado em 28/01/2016
    Entregue em 05/02/2016
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/02/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 07/06/2016Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 24/11/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 02/10/2006
    Entregue em 13/10/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/10/2006Registro de uma garantia (410)
    • 25/11/2010Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 03/05/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0