• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Daniel John DWYER - Página 145

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeDaniel
    Segundo NomeJohn
    Último NomeDWYER
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo0
    Renunciado5061
    Total5061

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    BALMORAL RENTALS LTD11/02/199111/02/1991DissolvidaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    RON SAUNDERS LIMITED28/01/199107/02/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    RON SAUNDERS LIMITED28/01/199107/02/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    31 ST GEORGE'S TERRACE (BRIGHTON) LIMITED29/01/199106/02/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    31 ST GEORGE'S TERRACE (BRIGHTON) LIMITED29/01/199106/02/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    BASE 1 LTD31/01/199105/02/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    BASE 1 LTD31/01/199105/02/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    EMTEL EUROPE LIMITED04/02/199104/02/1991DissolvidaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    EMTEL EUROPE LIMITED04/02/199104/02/1991DissolvidaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    REGALWEST LIMITED24/01/199101/02/1991LiquidaçãoDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    REGALWEST LIMITED24/01/199101/02/1991LiquidaçãoSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    TUCKER ACCOUNTING & BUSINESS SERVICES LIMITED24/01/199130/01/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    TUCKER ACCOUNTING & BUSINESS SERVICES LIMITED24/01/199130/01/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    SEA BREEZE (UK) LIMITED17/01/199129/01/1991DissolvidaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    SEA BREEZE (UK) LIMITED17/01/199129/01/1991DissolvidaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    EHC 25 CONSULTANTS LIMITED16/01/199116/01/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    EHC 25 CONSULTANTS LIMITED16/01/199116/01/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    BALMORAL HOMES (GUILDFORD) LIMITED16/01/199116/01/1991DissolvidaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    BALMORAL HOMES (GUILDFORD) LIMITED16/01/199116/01/1991DissolvidaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    RICHMOND FOODS LIMITED11/01/199115/01/1991AtivaDiretor nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British
    RICHMOND FOODS LIMITED11/01/199115/01/1991AtivaSecretário nomeado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0