• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Stephen MABBOTT - Página 61

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeStephen
    Último NomeMABBOTT
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo1
    Renunciado2448
    Total2449

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    GREENWOOD LIMITED11/08/199508/09/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BELLSIDE BUILDING & TIMBER SUPPLIES LIMITED07/09/199507/09/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BON ROY LIMITED06/09/199506/09/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    CAIRNHILL CONSTRUCTION LIMITED05/09/199505/09/1995LiquidaçãoDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BURNS REAL ALE LTD.30/08/199530/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    THAINSTONE LEASING CO. LTD.29/08/199529/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GREGOR MANAGEMENT LIMITED29/08/199529/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BELLTREE LIMITED25/08/199525/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GLENFIELD DEVELOPMENTS LIMITED25/08/199525/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    O'BRIEN SECURITY SERVICES LTD.21/08/199521/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    LOMOND COMPUTING SERVICES LIMITED21/08/199521/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    MINTO BRANDING LIMITED15/08/199515/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    YOYO RECORDS LIMITED15/08/199515/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GASGLOW LTD.11/08/199511/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    EVENROSE LIMITED11/08/199511/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    VOUCH SAFE LTD.11/08/199511/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    KMB SERVICES (SCOTLAND) LTD.08/08/199508/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    ACREMANOR LIMITED03/08/199503/08/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    HANISON ESTATES LIMITED01/08/199501/08/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    HAYBURN PROPERTIES LIMITED27/07/199527/07/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    EDINBURGH APARTMENTS LTD26/07/199526/07/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    HAMILTONS (STIRLING) LIMITED26/07/199526/07/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    RFL OFFICE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED21/07/199521/07/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SHETLAND ISLES LOGGING COMPANY LIMITED21/07/199521/07/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GROVEPARK LIMITED19/07/199519/07/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    MANOROAK LIMITED19/07/199519/07/1995LiquidaçãoDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    TRUMP DEVELOPMENTS LIMITED18/07/199518/07/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    THE ALPINE STORE LIMITED23/06/199512/07/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    DAVID HISLOP LTD.11/07/199511/07/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    FREEWAY FLEET SYSTEMS LIMITED10/07/199510/07/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    QUINN MCMAHON DESIGN LTD.29/06/199529/06/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    ARRAN SPORTS ASSOCIATION29/06/199529/06/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    MORAY OFFICE SUPPLIES LIMITED28/06/199528/06/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SPK (SYSTEMS) LIMITED27/06/199527/06/1995AtivaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    CCF WELL SERVICES LIMITED26/06/199526/06/1995DissolvidaDiretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0