Stephen George MABBOTT
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Stephen George MABBOTT - Página 145

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeStephen
    Segundo NomeGeorge
    Último NomeMABBOTT
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo23
    Renunciado9252
    Total9275

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    MONTY'S WORKTOP CENTRE LTD.20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE IMPERIAL BAR (SCOTLAND) LTD.20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ZENOBIA LIMITED20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MJW PROPERTY20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    ScotlandBritish
    TREADSTONE URBAN FURNISHINGS LTD.20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE APPSTILLERY LIMITED20/05/201020/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    NGL (SCOTLAND) LTD19/05/201019/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    ScotlandBritish
    BRUCKLAY GARAGE LTD.19/05/201019/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    BUSY FISH LTD.19/05/201019/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    STRAMASH PRODUCTION LTD.19/05/201019/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SMART ENGINEERING (SCOTLAND) LTD19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SCIPIO RESEARCH LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    FAIRWAYS LODGE HOTEL LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ABC GENERAL BUILDERS LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    JBM MECHANICAL SERVICES LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    PHD CATERING LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE CREATIVE HAIR COMPANY LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    BLUEJADE CONSULTANTS LTD19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MENTAL IMAGE PICTURES LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SRMA PROPERTY LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SCHIEHALLION PROJECT SERVICES LTD.19/05/201019/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    SHAWNIGAN LIFE LTD.19/05/201019/05/2010LiquidaçãoCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE KEMNAY CHIPPER LTD18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    INTELLICO CATERING EQUIPMENT LIMITED18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ALY BALI LTD18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    J.L. GILL LIMITED18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    WILLOW PHARMACY (DUNFERMLINE) LTD18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CHALLENGER ENERGY LIMITED18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    KHUNGHA PROPERTIES LIMITED18/05/201018/05/2010AtivaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    M SUTHERLAND PLANT SERVICES LTD.18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THAIN GARDNER LIMITED18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    BENVIEW ASSOCIATES LTD.18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    LJB BUSINESS SOLUTIONS LIMITED18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    JOHN SWEENEY AND SONS LTD.18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    FOREANDMORE LTD.18/05/201018/05/2010DissolvidaCompany Registration AgentDiretor
    Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    14
    United Kingdom
    ScotlandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0