Penelope Anne CHEATLE - Página 4
Pessoa Física
Título | |
---|---|
Primeiro Nome | Penelope |
Segundo Nome | Anne |
Último Nome | CHEATLE |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 2 |
Inativo | 19 |
Renunciado | 110 |
Total | 131 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENATOR P&A HOLDINGS UK LIMITED | 05/05/1999 | 25/06/1999 | Ativa | Company Secretary'S Assistant | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
HUNTSMAN POLYURETHANES (UK) LIMITED | 05/05/1999 | 25/06/1999 | Ativa | Company Secretary'S Assistant | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
HUNTSMAN POLYURETHANES SALES LIMITED | 05/05/1999 | 22/06/1999 | Ativa | Company Secretary'S Assistant | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED | 05/05/1999 | 07/06/1999 | Ativa | Company Secretary'S Assistant | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED | 05/05/1999 | 07/06/1999 | Ativa | Company Secretary'S Assistant | Secretário | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
LGC (NORTH WEST) LIMITED | 02/09/1997 | 30/10/1998 | Ativa | Company Official | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
LGC (NORTH WEST) LIMITED | 02/09/1997 | 30/10/1998 | Ativa | Company Official | Secretário | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
IMPKEMIX PROFIT SHARING SCHEME TRUSTEES LIMITED | 02/09/1997 | 19/10/1998 | Dissolvida | Company Official | Secretário | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
IMPKEMIX PROFIT SHARING SCHEME TRUSTEES LIMITED | 02/09/1997 | 19/10/1998 | Dissolvida | Company Official | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
ICI PAINTS ROYALTIES COMPANY LIMITED | 17/12/1993 | 07/07/1997 | Dissolvida | Company Official | Secretário | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
ICI PAINTS ROYALTIES COMPANY LIMITED | 17/12/1993 | 07/07/1997 | Dissolvida | Company Official | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | |
EPIGEM RESEARCH LIMITED | 17/12/1993 | 31/10/1995 | Ativa | Company Official | Secretário | Russet Vale Road BR1 2AL Bickley Kent | British | |
EPIGEM RESEARCH LIMITED | 17/12/1993 | 31/10/1995 | Ativa | Company Official | Diretor | Russet Vale Road BR1 2AL Bickley Kent | British | |
AFRICAN EXPLOSIVES INTERNATIONAL LIMITED | 01/05/1993 | 10/10/1995 | Ativa | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
AFRICAN EXPLOSIVES INTERNATIONAL LIMITED | 01/05/1993 | 15/06/1995 | Ativa | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
ICI PAINTS (TRADE CONTRACT) LIMITED | 17/12/1993 | 15/06/1995 | Dissolvida | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
ICI PAINTS (TRADE CONTRACT) LIMITED | 17/12/1993 | 15/06/1995 | Dissolvida | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 04/05/1993 | 17/06/1994 | Ativa | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
MORTAR INVESTMENTS UK LIMITED | 17/06/1994 | Ativa | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | ||
MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 04/05/1993 | 13/06/1994 | Ativa | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
MORTAR INVESTMENTS UK LIMITED | 13/06/1994 | Ativa | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | ||
ICI INTERNATIONAL LIMITED | 04/05/1993 | 26/01/1994 | Dissolvida | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
ICI INTERNATIONAL LIMITED | 01/05/1993 | 26/01/1994 | Dissolvida | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 01/05/1993 | 23/11/1993 | Ativa | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
ABB EUTECH LIMITED | 14/05/1993 | 01/07/1993 | Dissolvida | Company Official | Diretor | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | |
ABB EUTECH LIMITED | 14/05/1993 | 01/07/1993 | Dissolvida | Company Official | Secretário | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0