LYCIDAS NOMINEES LIMITED
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • LYCIDAS NOMINEES LIMITED - Página 13

    Executivo Corporativo

    NomeLYCIDAS NOMINEES LIMITED
    É Executivo CorporativoSim
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo8
    Renunciado439
    Total447

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaFunçãoEndereço
    KUC HOLDINGS LIMITED23/01/199213/03/1992DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    LOMOND SERVICE STATION LIMITED03/12/199106/02/1992AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    GLASGOW PRESTWICK AIRPORT LIMITED03/12/199104/02/1992AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    PRESTWICK AIRPORT LIMITED03/12/199104/02/1992AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    ADMIRAL ELECTRICAL (WHOLESALERS) LIMITED03/12/199113/12/1991LiquidaçãoDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    MERLIN SOLUTIONS LIMITED14/05/199101/10/1991AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    HEATHERGHYLL HOTELS LIMITED30/08/198830/06/1991AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    454 (STIRLING) LIMITED31/01/199128/06/1991AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    WHYTE & MACKAY DISTILLERS LIMITED31/01/199125/06/1991AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    KELVIN MANAGEMENT LTD.24/07/199019/06/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    AUCHINLECK DEVELOPMENTS LIMITED29/05/199009/06/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    REIVER VENTURES PROPERTIES LIMITED31/01/199103/05/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    J & D ROSE 2 LIMITED03/12/199021/03/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    ANNANDALE PROPERTIES LIMITED07/02/198907/02/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    INVERCLYDE SALES & SERVICE LIMITED15/11/199018/01/1991AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    MADISON CABLE LIMITED15/11/199015/01/1991DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    ARRIVA SCOTLAND WEST LIMITED15/11/199022/12/1990AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    GOOD MEDICINE19/07/198921/12/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    CENTRAL ADMIN SERVICES LIMITED29/08/198903/11/1990AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    REIVER VENTURES LIMITED22/09/198924/07/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    UNIVERSAL AUGERS LIMITED02/04/199016/05/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    OUTREACH LIMITED19/03/199026/04/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    RANFURLY ESTATES LIMITED22/09/198918/03/1990AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    TRICON AUTOMATION LIMITED07/02/198914/03/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    ALTER LIMITED04/07/198926/01/1990DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    ISLAY & JURA FERRY COMPANY LIMITED20/09/198831/12/1989AtivaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    RIMRAM LIMITED29/09/198823/10/1989DissolvidaDiretor nomeado
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0