APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииAPPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00091791
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    • (5243) /

    Где находится APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Юридический адрес
    DELOITTE LLP
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    STYLO BARRATT SHOES LIMITED23 янв. 1907 г.23 янв. 1907 г.

    Каковы последние отчеты APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на02 февр. 2008 г.

    Каков статус последней годовой декларации для APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    17 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 09 янв. 2015 г.

    17 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 09 янв. 2014 г.

    18 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 09 янв. 2013 г.

    17 страницы4.68

    Отчет о ходе администрации до 04 янв. 2012 г.

    33 страницы2.24B

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    26 страницы2.34B

    Прекращение полномочий Ronald Stark в качестве директора

    2 страницыTM01

    Отчет о ходе администрации до 25 июл. 2011 г.

    30 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 25 янв. 2011 г.

    46 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 25 янв. 2011 г.

    46 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Отчет о ходе администрации до 25 июл. 2010 г.

    33 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 25 июл. 2010 г.

    33 страницы2.24B

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    4 страницыMG02

    Отчет о ходе администрации до 25 янв. 2010 г.

    33 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Отчет о ходе администрации до 25 июл. 2009 г.

    31 страницы2.24B

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed stylo barratt shoes LIMITED\certificate issued on 06/05/09
    3 страницыCERTNM

    legacy

    1 страницы287

    Результат собрания кредиторов

    4 страницы2.23B

    Кто является должностными лицами APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    LOCKYER, David Edwin
    Halsdon House
    Luppitt
    EX14 4TR Honiton
    Devon
    Директор
    Halsdon House
    Luppitt
    EX14 4TR Honiton
    Devon
    EnglandBritishDirector127135560001
    ZIFF, Michael Anthony
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director9804810001
    STYLO PLC
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Stylo House
    Директор компании
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Stylo House
    134666020001
    BOTT, Richard Phillip
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    Секретарь
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    British43649330001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    Секретарь
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    BritishChartered Secretary139073520001
    ABEL, Richard William
    1 West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    1 West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    North Yorkshire
    BritishBuyer82537730001
    BOTT, Richard Phillip
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    Директор
    24 Ridgeway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JA Leeds
    Yorkshire
    UkBritishFinance Director43649330001
    BOWER, Richard Guy
    25 Pipistrelle Drive
    CV13 0NW Market Bosworth
    Warwickshire
    Директор
    25 Pipistrelle Drive
    CV13 0NW Market Bosworth
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector126483050001
    CLARKSON, Philip
    29 Church Rein Close
    DN4 9PG Doncaster
    South Yorkshire
    Директор
    29 Church Rein Close
    DN4 9PG Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector100862650001
    FOERS, Alan Edwin
    4 Woodside
    Utley
    BD20 6LF Keighley
    West Yorkshire
    Директор
    4 Woodside
    Utley
    BD20 6LF Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector31051680001
    FRANKEL, Michael
    Orchard House
    Horninghold
    LE16 8DH Market Harborough
    Leicestershire
    Директор
    Orchard House
    Horninghold
    LE16 8DH Market Harborough
    Leicestershire
    BritishDeputy Managing Director79694230001
    GEE, Peter Peregrine Simpson
    Thornton Manor
    Thornton Bridge, Helperby
    YO61 2RH York
    North Yorkshire
    Директор
    Thornton Manor
    Thornton Bridge, Helperby
    YO61 2RH York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director68168890002
    JEANES, Rebekah Mary
    53 West Cliffe Terrace
    HG2 0PU Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    53 West Cliffe Terrace
    HG2 0PU Harrogate
    North Yorkshire
    BritishLadies Buying Director75687480001
    LAWRENCE, Neville Jerome
    475 Harrogate Road
    LS17 7AE Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    475 Harrogate Road
    LS17 7AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector13840630001
    LEVIN, Richard Neil
    2 Windermere Drive
    LS17 7UZ Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    2 Windermere Drive
    LS17 7UZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishMerchandiser60193370001
    LEWIS, Stephen Vincent, Dr
    15 Crescent View
    Alwoodley
    LS17 7QF Leeds
    Директор
    15 Crescent View
    Alwoodley
    LS17 7QF Leeds
    UkBritishCompany Director11887090002
    LLOYD HUGHES, David
    5 Hollin Gardens
    Far Headingley
    LS16 5NL Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    5 Hollin Gardens
    Far Headingley
    LS16 5NL Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director55006410001
    MACKENZIE, Yvonne Mavis
    Green Bank Cottage
    Mellor Mill Lane, Holywell Green
    HX4 9AP Halifax
    West Yorkshire
    Директор
    Green Bank Cottage
    Mellor Mill Lane, Holywell Green
    HX4 9AP Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector72560370002
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    Директор
    Boothstown Drive
    Worsley
    M28 1UF Manchester
    18
    United KingdomBritishChartered Secretary139073520001
    MCLAUGHLAN, Roger
    67 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Директор
    67 Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishSales Director66713260001
    NATTRESS, Stephen
    17 Hollin Hall Lane
    Scapegoat Hill
    HD7 4PF Huddersfield
    West Yorkshire
    Директор
    17 Hollin Hall Lane
    Scapegoat Hill
    HD7 4PF Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishIs Director75687500002
    PATRICK, David Stephen
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Директор
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director94274510001
    PATRICK, David Stephen
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Директор
    10 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director94274510001
    ROBSON, Simon
    Dinwoodie 74 Kings Road
    LS29 9BZ Ilkley
    West Yorkshire
    Директор
    Dinwoodie 74 Kings Road
    LS29 9BZ Ilkley
    West Yorkshire
    The United KingdomBritishDirector69552680001
    STARK, Ron Arthur
    Near Woodside Farm
    Skipton Road
    BD20 9AB Kildwick
    North Yorkshire
    Директор
    Near Woodside Farm
    Skipton Road
    BD20 9AB Kildwick
    North Yorkshire
    EnglandBritishRetail Sales Manager167929430001
    UNWIN, Ian Myles
    37 Loxley Close
    Eccleshill
    BD2 3HX Bradford
    West Yorkshire
    Директор
    37 Loxley Close
    Eccleshill
    BD2 3HX Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector113895370001
    WEAVING, John Martin
    Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    15
    West Yorkshire
    Директор
    Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    15
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant137729810001
    ZIFF, Alan David
    31 Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    31 Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director11887080001

    Есть ли у APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH april 1993
    Создан 08 авг. 2005 г.
    Поставлен 11 авг. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 11 авг. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 июн. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5TH april 1993
    Создан 01 нояб. 2004 г.
    Поставлен 03 нояб. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 03 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 июн. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage and charge in favour of lloyds bank PLC capital markets as security trustee and
    Создан 16 апр. 1999 г.
    Поставлен 30 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Краткое описание
    All property and assets charged under the mortgage being hereditaments and premises situate on the south side of west street in the parish of st.peter and town of drogheda county of louth (now known as no. 3 west street drogheda) together with all that unit 208A eyre square centre city of galway. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC Capital Marketsas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Транзакции
    • 30 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 июн. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Guarantee and debenture in favour of lloyds bank PLC capital markets as security trustee
    Создан 26 мар. 1999 г.
    Поставлен 15 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 15 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 июн. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Letter of set-off
    Создан 16 нояб. 1983 г.
    Поставлен 01 дек. 1983 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 01 дек. 1983 г.Регистрация залога
    • 09 июн. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Supplemental trust deed
    Создан 05 июл. 1965 г.
    Поставлен 15 июл. 1965 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £2,000,000 inclusive of £1,000,000 secured by a trust deed dated 19/11/54
    Уполномоченные лица
    • Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 15 июл. 1965 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 19 янв. 1962 г.
    Поставлен 31 янв. 1962 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and deeds supplemental thereto
    Краткое описание
    66 london street, norwich together with all buildings erections and all fixed and movable plant machinery fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon.
    Уполномоченные лица
    • Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 31 янв. 1962 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 19 янв. 1962 г.
    Поставлен 31 янв. 1962 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and deeds supplemental thereto
    Краткое описание
    92 & 94 fore street hereford together with all building erections with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Уполномоченные лица
    • Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 31 янв. 1962 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of agreement and of substituted security
    Создан 06 сент. 1961 г.
    Поставлен 18 сент. 1961 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and deeds supplemental thereto
    Краткое описание
    66 london street, norwich.
    Уполномоченные лица
    • Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 18 сент. 1961 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 20 янв. 1961 г.
    Поставлен 24 янв. 1961 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £50,000
    Краткое описание
    9, st. Sepulchre gate, doncaster, yorks.
    Уполномоченные лица
    • H.N.Moss
    • H.A.Chetham
    Транзакции
    • 24 янв. 1961 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 19 янв. 1961 г.
    Поставлен 31 янв. 1961 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and a supplemental deed dated 21/11/56 and for increasing the rate of interest payable thereon
    Краткое описание
    Various properties as defined in the schedule (see doc 158 for full particulars).
    Уполномоченные лица
    • Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 31 янв. 1961 г.Регистрация залога
    • 03 сент. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 17 февр. 1960 г.
    Поставлен 03 мар. 1960 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and supplemental deed dated 21/11/56
    Краткое описание
    129,131,133,135,135A kensington high street london W8. Together will all buildings erections, & with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 03 мар. 1960 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 02 мар. 1959 г.
    Поставлен 16 мар. 1959 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and deed supplemental thereto
    Краткое описание
    51, high street, colchester, essex, together with plant machinery buildings fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 16 мар. 1959 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 30 сент. 1957 г.
    Поставлен 07 окт. 1957 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 & supplemental deed dated 21-11-56.
    Краткое описание
    3, corn market, halifax & 66 london st norwich, 41-45 (odd) powis street woolwich together with plant machinery, building, fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 07 окт. 1957 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge by way of substituted security
    Создан 11 февр. 1957 г.
    Поставлен 27 февр. 1957 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19/11/54 and supplemental deed dated 21-11-56
    Краткое описание
    44 & 46 the horsefair, bristol, 135, kensington high street london & 49-53 northumberland street newcastle-upon-tyne, together with plant machinery, buildings fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon belonging to the company.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 27 февр. 1957 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of variation
    Создан 21 нояб. 1956 г.
    Поставлен 23 нояб. 1956 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For increasing from 4 1/4% to 4 3/4% the rate of interest payable on £1,000,000 debenture stock secured by trust deed dated 19-11-54
    Краткое описание
    All the property charged by or pursuant to the trust deed dated 19-11-54.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 23 нояб. 1956 г.Регистрация залога
    • 03 сент. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Disposition registered at sasines on 3/5/1956
    Создан 03 мая 1956 г.
    Поставлен 11 мая 1956 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Securing debenture stock amounting to £1,000,000 secured by the trust deed dated 19/11/54
    Краткое описание
    44 murraygate dundee together with fixed plant, machinery and fixtures (including trade fixtures) thereon so far as heritable.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 11 мая 1956 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Disposition registered at sasines on 9/5/56
    Создан 29 мар. 1956 г.
    Поставлен 16 мая 1956 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing debenture stock amounting to £1,000,000 secured by trust deed dated 19/11/54
    Краткое описание
    12 & 13 south bridge & 15 niddry street edinburgh together with plant machinery fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or here after thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 16 мая 1956 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Disposition registered at sasines on 3/5/56
    Создан 29 мар. 1956 г.
    Поставлен 11 мая 1956 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing debenture stock amounting to £1,000,000 secured by trust deed dated 19/11/54
    Краткое описание
    159, 161, 163 sauchehall st. Glasgow together with fixed plant, machinery fixtures implements and utensils with all fixtures (including trade fixtures) now or here after thereon.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 11 мая 1956 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Disposition registered at sasines on 3/5/1956
    Создан 29 мар. 1956 г.
    Поставлен 11 мая 1956 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    For securing debenture stock amounting to £1,000,000 secured by trust deed dated 19/11/54
    Краткое описание
    123 1/2 & 125 union st aberdeen with all fixtures (including trade fixtures) now or here after thereon together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 11 мая 1956 г.Регистрация залога
    • 19 сент. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Trust deed
    Создан 19 нояб. 1954 г.
    Поставлен 30 нояб. 1954 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,000,000
    Уполномоченные лица
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Транзакции
    • 30 нояб. 1954 г.Регистрация залога
    • 03 сент. 1994 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у APPERLEY REALISATIONS NO 1 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    26 янв. 2009 г.Начало управления
    10 янв. 2012 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Практик
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    2
    ДатаТип
    10 янв. 2012 г.Начало ликвидации
    29 июн. 2016 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0