00117548 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компании00117548 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00117548
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель 00117548 LIMITED?

    • (5147) /

    Где находится 00117548 LIMITED?

    Юридический адрес
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты 00117548 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на05 апр. 2008 г.

    Какие последние документы подавались 00117548 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    страницы2.34B

    Восстановление по решению суда - ранее в добровольной ликвидации кредиторов

    3 страницыREST-CVL

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed stuart & sons\certificate issued on 19/10/22
    страницыCERTNM

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    38 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 10 мая 2016 г.

    46 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 08 мая 2015 г.

    57 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 10 мая 2014 г.

    64 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 08 мая 2013 г.

    58 страницы4.68

    Регистрация банкротства

    Insolvency:order of court removing angus matthew martin as liquidator of the company
    9 страницыLIQ MISC

    Уведомление о прекращении деятельности в качестве добровольного ликвидатора

    1 страницы4.40

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 10 мая 2012 г.

    46 страницы4.68

    Регистрация банкротства

    Insolvency:form 2.39B notice of vacation of office
    15 страницыLIQ MISC

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    25 страницы2.34B

    Отчет о ходе администрации до 04 янв. 2011 г.

    50 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Отчет о ходе администрации до 04 июл. 2010 г.

    54 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 04 янв. 2010 г.

    27 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 04 янв. 2010 г.

    48 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Отчет о ходе администрации до 04 июл. 2009 г.

    59 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 04 июл. 2009 г.

    30 страницы2.24B

    legacy

    1 страницы287

    Кто является должностными лицами 00117548 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GILLEN, Sinead
    7 Fortfield Collins Avenue
    Dunmore Road
    IRISH Waterford
    Ireland
    Секретарь
    7 Fortfield Collins Avenue
    Dunmore Road
    IRISH Waterford
    Ireland
    British111443530001
    CORBETT, Nigel
    16 Sister Dora Avenue
    WS7 9QD Burntwood
    Staffordshire
    Секретарь
    16 Sister Dora Avenue
    WS7 9QD Burntwood
    Staffordshire
    British55365650002
    FLYNN, Michael Thomas
    Winterwood
    96 Viewpoint
    IRISH Waterford
    Ireland
    Секретарь
    Winterwood
    96 Viewpoint
    IRISH Waterford
    Ireland
    Irish80546390001
    MORGAN, John Bernard
    Avila
    9 Greenfield Crescent
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4 Ireland
    Секретарь
    Avila
    9 Greenfield Crescent
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4 Ireland
    BritishCompany Secretary46821770001
    PAULI, David Stuart
    25 The Hope
    Stanton Lacy
    SY8 2AP Ludlow
    Salop
    Секретарь
    25 The Hope
    Stanton Lacy
    SY8 2AP Ludlow
    Salop
    British44058290001
    RICHMOND, Gerard Stuart
    14/55 Gloucester Road
    SW7 4QN London
    Секретарь
    14/55 Gloucester Road
    SW7 4QN London
    British78929740001
    BARNES, Richard Anthony
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    Директор
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritishDirector9859220001
    BLAKEMORE, Elizabeth
    25 Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Директор
    25 Mill Lane
    Wetley Rocks
    ST9 0BN Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director109714010001
    BRADLEY, William John
    13 Kings Court
    Kings Channel
    IRISH Waterford
    Ireland
    Директор
    13 Kings Court
    Kings Channel
    IRISH Waterford
    Ireland
    IrishFinance Director104570330001
    BROUGHAM, John Michael
    Greenrufe Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Директор
    Greenrufe Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector16686260001
    CLIST, Julian Reginald Brinton
    The Yard House
    Great Witley
    WR6 6JS Worcester
    Worcs
    Директор
    The Yard House
    Great Witley
    WR6 6JS Worcester
    Worcs
    EnglandBritishDirector3098820001
    DOWLING, Patrick John
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Директор
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    IrishCompany Director29859260001
    DOWNIE, Mark Lindsay
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    Директор
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary128949130001
    FEARON, John Anthony
    7 Kings Channel
    IRISH Waterford
    Ireland
    Директор
    7 Kings Channel
    IRISH Waterford
    Ireland
    IrishDirector44727790001
    FISHER, Brian Thomas
    15 Malvern Road
    Acocks Green
    B27 6EG Birmingham
    West Midlands
    Директор
    15 Malvern Road
    Acocks Green
    B27 6EG Birmingham
    West Midlands
    Great BritainBritishDirector18102310001
    FOLEY, John
    17 Eagle Valley
    Powerscourt Demesne
    IRISH Enniskerry
    Co Wicklow
    Ireland
    Директор
    17 Eagle Valley
    Powerscourt Demesne
    IRISH Enniskerry
    Co Wicklow
    Ireland
    AmericanCompany Director73774120001
    FYFE, David
    73 Weeping Cross
    ST17 0DQ Stafford
    Staffordshire
    Директор
    73 Weeping Cross
    ST17 0DQ Stafford
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant67558660002
    GALVIN, Edward Patrick
    Windrush
    4 Silver Birches
    IRISH Dundrum
    Dublin 4
    Ireland
    Директор
    Windrush
    4 Silver Birches
    IRISH Dundrum
    Dublin 4
    Ireland
    IrishDirector46821750001
    GORTON, Rosemary Ann
    39 Three Ashes Lane
    GL18 1DF Newent
    Gloucestershire
    Директор
    39 Three Ashes Lane
    GL18 1DF Newent
    Gloucestershire
    EnglandBritishHousewife/Farmer18781900001
    GRANGE, Anna Ruth
    Thornhill Farm
    SN16 0HL Malmesbury
    Wilts
    Директор
    Thornhill Farm
    SN16 0HL Malmesbury
    Wilts
    BritishFarmer9317940001
    JONES, Anthony Gerald
    Hill Road
    St Johns Wood
    NW8 9QE London
    5
    Директор
    Hill Road
    St Johns Wood
    NW8 9QE London
    5
    United KingdomBritishChief Financial Officer73644040004
    LASSETER, Margaret Mary
    Trelawn
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    Директор
    Trelawn
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    BritishRetailer13647820001
    MCGOOKIN, Colin
    4 Berkley Court
    Grantstown Village
    IRISH Waterford
    Ireland
    Директор
    4 Berkley Court
    Grantstown Village
    IRISH Waterford
    Ireland
    IrishCompany Director108273660001
    MORGAN, Mel Gerard
    118 Tiddington Road
    CV37 7BB Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Директор
    118 Tiddington Road
    CV37 7BB Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    IrishSales And Marketing Director54269920001
    O'DONOGHUE, Patrick Redmond
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Директор
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    IrishDirector77402680001
    PAGE, John Stuart
    The Centre For Natural Health
    52 Main Street Bridgend
    Perth
    Директор
    The Centre For Natural Health
    52 Main Street Bridgend
    Perth
    BritishOsteopath61048670001
    PAULI, David Stuart
    25 The Hope
    Stanton Lacy
    SY8 2AP Ludlow
    Salop
    Директор
    25 The Hope
    Stanton Lacy
    SY8 2AP Ludlow
    Salop
    BritishCompany Director44058290001
    PAULI, Roger Hamer
    Stourton Farm House
    Greensforge Lane
    DY7 5BD Stourbridge
    West Midlands
    Директор
    Stourton Farm House
    Greensforge Lane
    DY7 5BD Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director3264700001
    RICHMOND, Gerard Stuart
    14/55 Gloucester Road
    SW7 4QN London
    Директор
    14/55 Gloucester Road
    SW7 4QN London
    BritishTour Operator78929740001
    ROGERS, Gregory James
    Westfield
    Upper Ladyes Hill
    CV8 2FB Kenilworth
    Warwickshire
    Директор
    Westfield
    Upper Ladyes Hill
    CV8 2FB Kenilworth
    Warwickshire
    IrishCompany Director92365640001
    TEMPLE, John Alan
    9 Orchard Croft
    Guilden Sutton
    CH3 7SL Chester
    Директор
    9 Orchard Croft
    Guilden Sutton
    CH3 7SL Chester
    BritishCompany Director62721620001
    WILCOCK, Michael Joseph
    The Laurels
    London Road
    CW5 7JU Stapeley
    Cheshire
    Директор
    The Laurels
    London Road
    CW5 7JU Stapeley
    Cheshire
    BritishCompany Director95125050001

    Есть ли у 00117548 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Trademark security agreement
    Создан 20 дек. 2005 г.
    Поставлен 05 янв. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors (including the company) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The trademarks referred to in exhibit a to the trademark security agreement (as shown in schedule 1) including without limitation all common law rights therein all registrations ii) all licenses associated with the use of any such trademarks iii) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of America, N.A.
    Транзакции
    • 05 янв. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of debenture
    Создан 20 дек. 2005 г.
    Поставлен 05 янв. 2006 г.
    Частично погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of America N.A. (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 05 янв. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 30 сент. 2004 г.
    Поставлен 07 окт. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Burdale Financial Limited
    Транзакции
    • 07 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Trademark security agreement
    Создан 30 сент. 2004 г.
    Поставлен 07 окт. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All of the trademarks referred to in exhibit a to the agreement including all common law rights, all registrations, all applications for the registration, all renewals and extensions and all goodwill connected with the use of such trademarks, all associated licences, all products and proceeds of the foregoing including any claim against third parties for the infringement of any such trademarks or goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Burdale Financial Limited
    Транзакции
    • 07 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    An intercreditor and security trust agreement
    Создан 26 нояб. 2003 г.
    Поставлен 17 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to a senior creditor or to an hyb creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    If the company receives from a third party a payment or distribution which should have been paid to the security trustee or a creditor the company must promptly pay to the security trustee the amount received by it and required to be prepaid any amount so received by the company from the third party shall be held by it on trust until such payment is made any amount so received by the security trustee will be applied against the debt in the order provided for under the intercreditor. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 17 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 окт. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A trademark security agreement
    Создан 26 нояб. 2003 г.
    Поставлен 16 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All of the guarantors right title and interest in to and under the following, all of the trademarks all registrations all applications for the registration all renewals and extensions and all of the goodwill of the business all licences associated with the use of any of such trademarks. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 окт. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security agreement
    Создан 26 нояб. 2003 г.
    Поставлен 09 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 окт. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 17 мая 1991 г.
    Поставлен 28 мая 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property k/a 24-25 williamson square, liverpool and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 28 мая 1991 г.Регистрация залога
    • 30 сент. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 14/4/88
    Создан 14 апр. 1988 г.
    Поставлен 23 апр. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Ground at south bridgend crieff in the county of perth extending to 2.49 acres with the glassworks k/a stratheam glassworks and others erected thereon.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 23 апр. 1988 г.Регистрация залога
    • 30 сент. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 28 апр. 1980 г.
    Поставлен 01 мая 1980 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H land & premises the white glass house, corn mill, wordsley, f/h land & premises red house glass works, wordsley. F/h land & premises 1-6 vine st wordsley. F/h land & premises 7-12 vine st, wordsley. F/h land & premises adjoining stourbridge canal wordsley. F/h land & premises at audnam. F/h land & premises at the lower ashwood farm & baryons field wordsley. F/h land & premises at vine st wordsley. F/h land on south east side of vine st camp hill, wordsley. F/h land on south west side of vine st, wordsley. F/h land & premises at aberbargoed monmouth. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank LTD
    Транзакции
    • 01 мая 1980 г.Регистрация залога
    • 30 сент. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у 00117548 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    05 янв. 2009 г.Начало управления
    11 мая 2011 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Angus Matthew Martin
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Практик
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Практик
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Практик
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Практик
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    2
    ДатаТип
    11 мая 2011 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Angus Matthew Martin
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Практик
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0