SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSELECTA REFRESHMENTS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00157122
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Finway Road Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SELECTA UK LIMITED20 янв. 2003 г.20 янв. 2003 г.
    VENDEPAC LIMITED01 мая 1998 г.01 мая 1998 г.
    TM GROUP LIMITED12 мая 1986 г.12 мая 1986 г.
    MAYFAIR GROUP LIMITED31 дек. 1981 г.31 дек. 1981 г.
    STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED16 июл. 1919 г.16 июл. 1919 г.

    Каковы последние отчеты SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2022 г.

    Какие последние документы подавались SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    12 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мар. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Юридический адрес изменен с Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England на 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT 15 нояб. 2022 г.

    1 страницыAD01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мар. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    12 страницыAA

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    12 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мар. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Anthony Michael Leon в качестве директора 01 апр. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Paul Nathaniel Ian Hearne на должность директора 01 апр. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    16 страницыAA

    legacy

    68 страницыPARENT_ACC

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    Назначение Mr Anthony Michael Leon на должность директора 20 окт. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Marta Schwartz в качестве директора 20 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мар. 2020 г. с изменениями

    3 страницыCS01

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA

    Процедура принудительной ликвидации прекращена

    1 страницыDISS40

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Назначение Marta Schwartz на должность директора 01 сент. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr.
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Директор
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish124527170003
    VRIJLANDT, Jan Marck
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Директор
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch201873380001
    BAKER, Roger Owen
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    Секретарь
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    British18801330003
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Секретарь
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Секретарь
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Секретарь
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MERCER, Roderick
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    Секретарь
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    British129465490001
    MILLER, Simon Jonathan
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    Секретарь
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    British88269280001
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    Секретарь
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    British147336500001
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Секретарь
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Директор
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritish183822370001
    BATE, David Martin
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    Директор
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    British130717000002
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Директор
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    Директор
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritish451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    Директор
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    British36622820001
    BURROWS, Helen
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    Директор
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish171865220001
    COWING, Helen
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    Директор
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    NetherlandsBritish156849560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Директор
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    CULLENS, Alan
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Директор
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    British6875310001
    HUGHES, Geraint
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Директор
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    SwitzerlandBritish169470320001
    JONES, Dylan Glynn
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Директор
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish153523810001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    British56997350002
    LANCASTER, James
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Директор
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    EnglandBritish147052660001
    LEON, Anthony Michael
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Директор
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    EnglandBritish242255050001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Директор
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish12314170002
    MAUGUY, Philippe Francis Robert
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Директор
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish, French179402830001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Директор
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    MEE, Andy Edward
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    Директор
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    EnglandBritish177086470001
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    Директор
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    British6907290001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish124498400001
    PORTER, Andrew Graham
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Директор
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish64331540001
    SCHWAB, Martin
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    Директор
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss123132130001
    SCHWARTZ, Marta
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Директор
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    United KingdomPolish262359470001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    19 дек. 2017 г.
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland & Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер00209116
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Kkr & Co.L.P
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    06 апр. 2016 г.
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    Да
    Организационно-правовая формаLimited Partnership
    Страна регистрацииDelaware
    Юридическое основаниеDelaware
    Место регистрацииRegistered In Delaware
    Регистрационный номерState File No. 4378294
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у SELECTA REFRESHMENTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 27 февр. 2017 г.
    Поставлен 01 мар. 2017 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Factofrance
    Транзакции
    • 01 мар. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 20 июн. 2014 г.
    Поставлен 26 июн. 2014 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Транзакции
    • 26 июн. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    • 07 февр. 2018 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Rent deposit deed
    Создан 13 янв. 2012 г.
    Поставлен 27 янв. 2012 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Wgtc Nominees Limited
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    Транзакции
    • 27 янв. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    Fixed and floating secuirty document
    Создан 28 сент. 2007 г.
    Поставлен 10 окт. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank Pls as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Транзакции
    • 10 окт. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 янв. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Charge over deposit
    Создан 08 дек. 2000 г.
    Поставлен 19 дек. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents
    Краткое описание
    1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 19 дек. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 28 нояб. 1998 г.
    Поставлен 08 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge over deposit account
    Создан 10 июл. 1998 г.
    Поставлен 27 июл. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined)
    Краткое описание
    The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC; As Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Транзакции
    • 27 июл. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed
    Создан 10 июл. 1998 г.
    Поставлен 27 июл. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland P.L.C.; As Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Транзакции
    • 27 июл. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed
    Создан 17 апр. 1998 г.
    Поставлен 23 апр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995
    Краткое описание
    Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC(Security Trustee)
    Транзакции
    • 23 апр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental legal charge
    Создан 06 дек. 1996 г.
    Поставлен 09 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995
    Краткое описание
    L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Share pledge
    Создан 24 июл. 1995 г.
    Поставлен 02 авг. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Транзакции
    • 02 авг. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Share pledge
    Создан 24 июл. 1995 г.
    Поставлен 02 авг. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Краткое описание
    Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Транзакции
    • 02 авг. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июл. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 24 июл. 1995 г.
    Поставлен 31 июл. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Краткое описание
    L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 31 июл. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 апр. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0