SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSHEARINGS HOLIDAYS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00218550
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    • Прочие вспомогательные виды деятельности, связанные с наземными перевозками, н.в.и.д. (52219) / Транспорт и хранение

    Где находится SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Ernst & Young Llp
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    WA SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED13 мар. 2006 г.13 мар. 2006 г.
    SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED18 окт. 1989 г.18 окт. 1989 г.
    PLEASURAMA HOLIDAYS LIMITED01 окт. 1987 г.01 окт. 1987 г.
    NATIONAL HOLIDAYS LIMITED31 дек. 1980 г.31 дек. 1980 г.
    SHEFFIELD UNITED TOURS LIMITED30 дек. 1926 г.30 дек. 1926 г.

    Каковы последние отчеты SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Уведомление о переходе от администрации к роспуску

    41 страницыAM23

    Отчет о ходе администрации

    40 страницыAM10

    Отчет о ходе администрации

    41 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    41 страницыAM10

    Отчет о ходе администрации

    43 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    49 страницыAM10

    Прекращение полномочий Richard James Calvert в качестве директора 29 мая 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Paul David Smith в качестве директора 17 июл. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    4 страницыAM06

    Заявление о предложениях администратора

    90 страницыAM03

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA

    11 страницыAM02

    Прекращение полномочий a G Secretarial Limited в качестве секретаря 22 мая 2020 г.

    2 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom на C/O Ernst & Young Llp 2 st Peters Square Manchester M2 3EY 10 июн. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    3 страницыAM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 21 мар. 2020 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    24 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 21 мар. 2019 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Прекращение полномочий Gary Speakman в качестве директора 31 дек. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Paul David Smith на должность директора 01 окт. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Vincent Flower в качестве директора 01 окт. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    22 страницыAA

    Изменение данных директора для Graham John Rogers 12 сент. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Кто является должностными лицами SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director69494710002
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Секретарь
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Секретарь
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Секретарь
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Секретарь компании
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BARNES, Christopher
    19 Chatsworth Court
    Heath Charnock
    PR6 9SA Chorley
    Lancashire
    Директор
    19 Chatsworth Court
    Heath Charnock
    PR6 9SA Chorley
    Lancashire
    BritishProduct Director51002220001
    BLACKBOURN, Leslie Richard
    86 Hob Hey Lane
    WA3 4NW Culchech
    Warrington
    Директор
    86 Hob Hey Lane
    WA3 4NW Culchech
    Warrington
    BritishCompany Director57674380001
    BROWN, Caroline Louise
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishCommercial Director138682210001
    BURKE, Jane Bain
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51003380001
    BURKE, Jane Bain
    3 Holgrave Close
    High Legh
    WA16 6TX Knutsford
    Cheshire
    Директор
    3 Holgrave Close
    High Legh
    WA16 6TX Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishPersonnel Director51003380001
    CALVERT, Richard James
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    Директор
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    EnglandBritishCeo163434180002
    CONNOR, Ruth Joanne
    WN3 4AG Wigan
    Miry Lane
    Lancashire
    Директор
    WN3 4AG Wigan
    Miry Lane
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director154083710001
    CRICHTON-MILLER, Hugh Angus
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    Директор
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    BritishDirector16687350001
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Директор
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    BritishCompany Secretary26244410001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    FREEMAN, Paul Stephen
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishAccountant52600500001
    HAWE, Brian Kingsley Arthur
    3 Stonehill Drive
    OL12 7JN Rochdale
    Lancashire
    Директор
    3 Stonehill Drive
    OL12 7JN Rochdale
    Lancashire
    BritishProduct Director51002260001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Директор
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    MACLEAN, Alan Kenneth
    Teston Road
    ME19 5NJ Offham
    The Old Forge
    Kent
    Директор
    Teston Road
    ME19 5NJ Offham
    The Old Forge
    Kent
    United KingdomBritishCommercial Director130948230001
    MORLEY, Melvyn Ernest
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishProduct Director51002210001
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director30276880001
    NORTH, Terence Henry
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    Директор
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    BritishDirector33990450001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Директор
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishDirector104434750001
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Директор
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34191470001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер5272464
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Guarantee and set-off agreement
    Создан 20 апр. 2006 г.
    Поставлен 05 мая 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 20 апр. 2006 г.
    Поставлен 05 мая 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 31 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 31 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 30 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 30 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 04 нояб. 2002 г.
    Поставлен 12 нояб. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Interchange passenger interchange, junction 4A, motorway, barnet. Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 12 нояб. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 18 дек. 1996 г.
    Поставлен 24 дек. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Транзакции
    • 24 дек. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 июн. 1999 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 15 июн. 1999 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 14 нояб. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    22 мая 2020 г.Начало управления
    24 мая 2023 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Практик
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Практик
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0