RECORD SHOP 2 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииRECORD SHOP 2 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00229249
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель RECORD SHOP 2 LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Юридический адрес
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    HMV MUSIC LIMITED08 мая 1998 г.08 мая 1998 г.
    EMI GROUP HOME ELECTRONICS (UK) LIMITED16 авг. 1996 г.16 авг. 1996 г.
    THORN EMI HOME ELECTRONICS (UK) LIMITED28 апр. 1986 г.28 апр. 1986 г.
    HMV SHOPS LIMITED31 дек. 1980 г.31 дек. 1980 г.
    EMI RECORD SHOPS LIMITED29 мар. 1928 г.29 мар. 1928 г.

    Каковы последние отчеты RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на28 апр. 2012 г.

    Какие последние документы подавались RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    22 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 16 июл. 2019 г.

    21 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 16 июл. 2018 г.

    25 страницыLIQ03

    Удаление ликвидатора по судебному приказу

    9 страницыLIQ10

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 16 июл. 2017 г.

    22 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 16 июл. 2016 г.

    23 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 16 июл. 2015 г.

    17 страницы4.68

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    3 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    3 страницыF10.2

    Уведомление в торговый реестр об отказе от имущества

    3 страницыF10.2

    Отчет о ходе администрации до 16 июл. 2014 г.

    26 страницы2.24B

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Отчет о ходе администрации до 30 июн. 2014 г.

    29 страницы2.24B

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    1 страницы2.34B

    Отчет о ходе администрации до 31 мая 2014 г.

    29 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 30 нояб. 2013 г.

    36 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Отчет о ходе администрации до 14 июл. 2013 г.

    32 страницы2.24B

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed hmv music LIMITED\certificate issued on 30/04/13
    2 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name30 апр. 2013 г.

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    2 страницыF2.18

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    4 страницыF2.18

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    6 страницыF2.18

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    4 страницыF2.18

    Кто является должностными лицами RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Секретарь
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Секретарь
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    GEERS, James Alfred
    33 Private Road
    EN1 2EH Enfield
    Middlesex
    Секретарь
    33 Private Road
    EN1 2EH Enfield
    Middlesex
    British942060001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Секретарь
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    BritishCompany Secretary62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Секретарь
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Секретарь
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    British40470020001
    MURRAY, Wayne Roger
    Glebe House
    Southend Bradfield
    Reading
    Berkshire
    Секретарь
    Glebe House
    Southend Bradfield
    Reading
    Berkshire
    British2581850001
    RITCHIE, Alistair John
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    Секретарь
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    British6417760001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Секретарь
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Секретарь
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    ANDERSON, Douglas Donald
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    Директор
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    AmericanDirector31392950001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Директор
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    BritishDirector9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Директор
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director180993450001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Директор
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    BritishDirector27960300001
    CAMPBELL, Ronald Alexander Lamont
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    Директор
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector7919580002
    CHARLTON, Robin
    Bullbeggars Lodge
    Potten End
    HP4 2RS Berkhamsted
    Hertfordshire
    Директор
    Bullbeggars Lodge
    Potten End
    HP4 2RS Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary14721300001
    DUFFY, Simon Patrick
    Galionsvej 42
    1437 Copenhagen K
    Denmark
    Директор
    Galionsvej 42
    1437 Copenhagen K
    Denmark
    BritishGroup Finance Director78047990001
    FEAVIOUR, Nicholas David
    Fir Tree House
    18 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    Директор
    Fir Tree House
    18 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    BritishTreasurer83587700001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Директор
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Директор
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Executive156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Директор
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritishCompany Secretary62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Директор
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    EnglandBritishDirector107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Директор
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritishHuman Resources Director76768320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Директор
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritishDirector76768320001
    MARRINER, Elaine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Директор
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    EnglandBritishChartered Secretary40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Директор
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    BritishDirector9406880001
    METCALF, Michael Edward
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Директор
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandBritishDirector61013220001
    MILES, Martin Terence
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Директор
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant124119090001
    MOORE, Trevor Philip
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Директор
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritishDirector113047410001
    SMITH, George Marsden
    71 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    Директор
    71 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    BritishSolicitor15729150001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Директор
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63502600001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Директор
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63502600001
    WOOD, Christopher John
    Flat J
    The Dormy House Portnall Drive
    GU25 4NP Wentworth
    Surrey
    Директор
    Flat J
    The Dormy House Portnall Drive
    GU25 4NP Wentworth
    Surrey
    BritishDirector44524800001

    Есть ли у RECORD SHOP 2 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Security interest agreement
    Создан 30 июн. 2011 г.
    Поставлен 01 июл. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each grantor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The collateral being- 2A ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company and the derivative assets see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Транзакции
    • 01 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Security agreement
    Создан 30 июн. 2011 г.
    Поставлен 01 июл. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Транзакции
    • 01 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Commercial trading terms and terms and conditions of trade
    Создан 20 янв. 2011 г.
    Поставлен 21 янв. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The title to and ownership of any goods delivered until such time as the supplier has been paid in full in respect of all goods in relation to an individual; and all other goods supplied under the terms whatsoever see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Universal Pictures (UK) Limited
    Транзакции
    • 21 янв. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 03 авг. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 03 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 25 сент. 2009 г.
    Поставлен 08 окт. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 08 окт. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 11 may 2009 and
    Создан 17 июл. 2009 г.
    Поставлен 24 июл. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 24 июл. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 11 мая 2009 г.
    Поставлен 12 мая 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 12 мая 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Security agreement
    Создан 31 мар. 2005 г.
    Поставлен 08 апр. 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due of each obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The f/h & l/h property, rights in respect of the contracts or policies of insurance and all rights in respect of know-how, patent, trade amrk, service mark, design, business name, topographical or similar right. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 08 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    Supplemental security agreement
    Создан 05 авг. 2003 г.
    Поставлен 21 авг. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first floating charge all the assets and the whole of the undertaking present and future.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Транзакции
    • 21 авг. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security agreement
    Создан 15 мая 2002 г.
    Поставлен 24 мая 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the secured parties (the "facility agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 24 мая 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 апр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28TH march 1998
    Создан 13 авг. 2001 г.
    Поставлен 14 авг. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as defined in the debenture) on the terms and conditions set out in the senior facility agreement dated 25TH february 1998 (the "security agent") under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in resepct of any further advances made thereunder
    Краткое описание
    L/H premises as ground floor 19-23 oxford street and 1-6 falconberg court london W1 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 14 авг. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 02 мар. 1999 г.
    Поставлен 03 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture)
    Краткое описание
    The leasehold premises known as unit 1 royal house, prices gate, homer road, solihull, west midlands title number WM620352 all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery rights, title supplier or installer of such property any builder any lessee, sub-lessee or licensee of other property hiring leasing rental contract guarantee indemnity or security covenants agreements undertakings or obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ubs Ag (The Security Agent) as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 03 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 11 дек. 1998 г.
    Поставлен 23 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability which the company may now or in the future have to the chargee as trustee for the beneficiaries ("the security agent") or any of the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture)including any liability in respect of further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum now or hereafter owing,due or incurred by the company
    Краткое описание
    L/H premises k/a 82 gower street and 42/56 torrington place london W1 t/n NGL589565 (the other principal property) and the real property all estates or interest in f/h or l/h propertyt and all buildings trade and other fixtures fixed plant and macxhniery for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ubs Ag
    Транзакции
    • 23 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge supplemental to the debenture dated 22ND may 1998
    Создан 22 мая 1998 г.
    Поставлен 08 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior facility agreement dated 25TH february 1998 (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the principal leasehold property known as unit S9,the bentall centre,kingston-u-thames;all rights and claims thereunder and the benefit of the agreements for sale/lease. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Swiss Bank Corporation,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Транзакции
    • 08 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 22 мая 1998 г.
    Поставлен 04 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Транзакции
    • 04 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Создан 22 мая 1998 г.
    Поставлен 03 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Транзакции
    • 03 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND june 1998
    Создан 18 мая 1998 г.
    Поставлен 10 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Краткое описание
    Lease of 172,174 and 176 argyle street glasgow GLA97005.
    Уполномоченные лица
    • Swiss Bank Corporation
    Транзакции
    • 10 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 4TH june 1998
    Создан 18 мая 1998 г.
    Поставлен 10 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Краткое описание
    Lease of 269 and 271 union street aberdeen ABN3659.
    Уполномоченные лица
    • Swiss Bank Corporation
    Транзакции
    • 10 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Создан 14 мая 1998 г.
    Поставлен 15 мая 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Транзакции
    • 15 мая 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 28 мар. 1998 г.
    Поставлен 09 апр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the senior facility agreement
    Краткое описание
    L/H first floor offices 40 west street marlow bucks t/n BM112289 unit 2 roman gate high street exeter t/n DN270835 2/4 st ann's square and 3,5,7 barton square manchester t/n GM590998 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Swiss Bank Corporation(Security Agent)
    Транзакции
    • 09 апр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 28 мар. 1998 г.
    Поставлен 09 апр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Транзакции
    • 09 апр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мая 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у RECORD SHOP 2 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    15 янв. 2013 г.Начало управления
    17 июл. 2014 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Практик
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Практик
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    2
    ДатаТип
    17 июл. 2014 г.Начало ликвидации
    01 янв. 2021 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Предлагаемый ликвидатор
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Robert James Harding
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Предлагаемый ликвидатор
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Предлагаемый ликвидатор
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Robert James Harding
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Практик
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0