BPT LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBPT LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00229269
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BPT LIMITED?

    • Покупка и продажа собственной недвижимости (68100) / Операции с недвижимым имуществом
    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится BPT LIMITED?

    Юридический адрес
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BPT LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BRADFORD PROPERTY TRUST PLC(THE)30 мар. 1928 г.30 мар. 1928 г.

    Каковы последние отчеты BPT LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается30 сент. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июн. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для BPT LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на18 июл. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено01 авг. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на18 июл. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались BPT LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Назначение Mrs Sapna Bedi Fitzgerald на должность секретаря 30 сент. 2024 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Adam Mcghin в качестве секретаря 27 сент. 2024 г.

    1 страницыTM02

    Прекращение полномочий Adam Mcghin в качестве директора 27 сент. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mrs Sapna Bedi Fitzgerald на должность директора 30 сент. 2024 г.

    2 страницыAP01

    Уведомление о Grainger Plc как лице, осуществляющем значительный контроль, 01 окт. 2021 г.

    2 страницыPSC02

    Прекращение полномочий Bromley Property Investments Limited как лица, осуществляющего значительный контроль, 01 окт. 2021 г.

    1 страницыPSC07

    Уведомление о подтверждении, составленное 18 июл. 2024 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    24 страницыAA

    legacy

    188 страницыPARENT_ACC

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    Отчет о капитале после размещения акций 26 июл. 2023 г.

    • Капитал: GBP 138,380,871.2
    3 страницыSH01

    Изменение данных директора для Mr Adam Mcghin 01 сент. 2023 г.

    2 страницыCH01

    Уведомление о подтверждении, составленное 18 июл. 2023 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    23 страницыAA

    legacy

    176 страницыPARENT_ACC

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение об изменении прав или наименования акций

    RES12

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Re-section 630 23/01/2023
    RES13

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Re-section 630 23/01/2023
    RES13

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 30 янв. 2023 г.

    • Капитал: GBP 135,559,112.05
    3 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Кто является должностными лицами BPT LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Секретарь
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    328057620001
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishSolicitor327770380001
    GERVAISE-JONES, Henry Barnaby
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector253058340002
    GORDON, Helen Christine
    St. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Директор
    St. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director59902650002
    HUDSON, Robert Jan
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director201533990002
    PATTINSON, Eliza
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Директор
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257770240001
    DENBY, Nigel Anthony
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    Секретарь
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant33799980001
    DENBY, Nigel Anthony
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    Секретарь
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant33799980001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Секретарь
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    HALLIWELL, Christine
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    Секретарь
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    British66463330001
    MCGHIN, Adam
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Секретарь
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    206240320001
    TETLEY, Brian
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    Секретарь
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    British669890001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Секретарь
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    WOOD, Timothy Barry
    Littlebeck House 18 Nursery Lane
    Addingham
    LS29 0TN Ilkley
    West Yorkshire
    Секретарь
    Littlebeck House 18 Nursery Lane
    Addingham
    LS29 0TN Ilkley
    West Yorkshire
    British7212090002
    AUSTIN, Toby Edward
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Директор
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector248037200002
    BAKER, David Graham
    St Michaels
    Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Директор
    St Michaels
    Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishProperty Manager55556410001
    BRUSH, David Michael
    21 Prince Albert Road
    NW1 7ST London
    Директор
    21 Prince Albert Road
    NW1 7ST London
    United KingdomAmericanBanker108278590001
    BURGESS, Harold Reginald John
    High Croft
    Whydown
    TN39 4RB Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    Директор
    High Croft
    Whydown
    TN39 4RB Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    BritishEstate Manager669900001
    BUTTERWORTH, Gary Ronald
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    Директор
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    BritishProperty Manager63723110001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Директор
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritishDirector Of Equity Release156117090001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Директор
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant74581390003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Директор
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishChartered Accountant65421150003
    DENBY, Nigel Anthony
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    Директор
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant33799980001
    DENHAM, Nigel Robert Algernon
    Spinalonga Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8SD Halifax
    West Yorkshire
    Директор
    Spinalonga Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8SD Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector3100070001
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Директор
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Директор
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishChartered Accountant8256950001
    DIXON, Alistair William
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    Директор
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    United KingdomBritishCompany Director49174270004
    FLEETWOOD, Mark Christopher
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishCorporate Finance Director282530860001
    FOOKS, John Anthony
    Woodgate House
    Beckley
    TN31 6UH Rye
    East Sussex
    Директор
    Woodgate House
    Beckley
    TN31 6UH Rye
    East Sussex
    EnglandBritishDirector119150002
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Директор
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    EnglandEnglishAccountant86483290001
    GREENWOOD, Mark
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director154194730002
    GRESSWELL, Peter Donald
    College House
    Stanton St John
    OX33 1HE Oxford
    Oxfordshire
    Директор
    College House
    Stanton St John
    OX33 1HE Oxford
    Oxfordshire
    BritishChartered Surveyor14784140001
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishDirector60099210003
    KEMBALL, Christopher Ross Maguire
    33 Brook Green
    W6 7BL London
    Директор
    33 Brook Green
    W6 7BL London
    United KingdomBritishSenior Managing Director131029730001
    MCGHIN, Adam
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Директор
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor169082950002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над BPT LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    01 окт. 2021 г.
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаPublic Limited Company (Listed)
    Страна регистрацииEngland & Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England & Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер00125575
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Да
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland & Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England & Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер4066391
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у BPT LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 01 окт. 2015 г.
    Поставлен 16 окт. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    As more particularly described in clause 3 of the legal charge, a legal charge over 1 ordinary share held by bpt limited in grainger bradley limited together with distribution rights.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 16 окт. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 01 окт. 2015 г.
    Поставлен 16 окт. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Short description of any land (including buildings), ship, aircraft or ip registered (or required to be registered) in the UK which is subject to this fixed charge or fixed security. As more particularly described in clause 3 of the legal charge, a legal charge over 17,779,532 ordinary shares held by bpt limited in grainger southwark limited together with distribution rights.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 16 окт. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 01 окт. 2015 г.
    Поставлен 16 окт. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    As more particularly described in clause 3 of the legal charge, a legal charge over 1,000,000 shares of each of classes a to f held by bpt limited in pha limited together with distribution rights.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 16 окт. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    Legal charge over shares
    Создан 26 февр. 2013 г.
    Поставлен 13 мар. 2013 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage the shares and by way of equitable mortgage the distribution rights meaning all dividends distributions interest and other income paid or payable on any share see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 13 мар. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    Legal charge over shares
    Создан 26 февр. 2013 г.
    Поставлен 13 мар. 2013 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage the shares and by way of equitable mortgage the distribution rights meaning all dividends distributions interest and other income paid or payable on any share see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 13 мар. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    Legal charge over shares
    Создан 26 февр. 2013 г.
    Поставлен 13 мар. 2013 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage the shares and by way of equitable mortgage the distribution rights meaning all dividends distributions interest and other income paid or payable on any share see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Транзакции
    • 13 мар. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    Share charge
    Создан 19 дек. 2008 г.
    Поставлен 29 дек. 2008 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from hamsard 2518 limited to the security deneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    For good and valuable consideration receipt of which is acknowledged the chargor as security for the secured liabilities mortgages and charges and agrees to mortgage and charge to the security trustee by way of a first equitable mortgage the shares and all their related rights (fixed charge asets).
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent, Arranger and Security Trustee
    Транзакции
    • 29 дек. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    Share charge
    Создан 12 июл. 2002 г.
    Поставлен 26 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from hamsard 2518 limited to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    First equitable mortgage, the shares and all their related rights (together, the "fixed charge assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Транзакции
    • 26 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 мая 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A security interest agreement
    Создан 12 июн. 2002 г.
    Поставлен 27 июн. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    2 shares of £1 each in mirabeay llimited and 2 shares of £1 each in comino limited and all shares stocks securities distributions dividends interest or other income deriving from the same.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society
    Транзакции
    • 27 июн. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignation of rents
    Создан 10 янв. 2002 г.
    Поставлен 24 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and others to the chargee
    Краткое описание
    Whole rights title and interest in and to the rent and all other monies due and to become due to it in terms of the lease affecting the scottish property.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society
    Транзакции
    • 24 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 04 january 2002 and
    Создан 14 дек. 2001 г.
    Поставлен 17 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole those plots or areas of ground together with the dwellinghouses and others erected thereon known as and forming numbers 51 and 110 geils avenue dumbarton in the county of dumbarton forming part of and all and whole that plot of ground lying in the parish of old kilpatrick and burgh and county of dumbarton containing 5.576 acres or thereby forming part of the fields or enclosures numbered 157,161 and 162 on the ordnance survey map. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society as Security Trustee for the Securitybeneficaries
    Транзакции
    • 17 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society
    Создан 16 нояб. 2001 г.
    Поставлен 22 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society
    Транзакции
    • 22 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 янв. 2003 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 21 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of accession and variation to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society
    Создан 16 нояб. 2001 г.
    Поставлен 22 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nationwide Building Society
    Транзакции
    • 22 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 янв. 2003 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 21 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of covenant.
    Создан 21 дек. 1994 г.
    Поставлен 04 янв. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Amenity land situate at hilton road, martlesham heath ,suffolk.
    Уполномоченные лица
    • Secretary of State for Defence.
    Транзакции
    • 04 янв. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 нояб. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Equitable charge
    Создан 04 дек. 1984 г.
    Поставлен 17 дек. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    Hamlet 1, phase 2 martlesham heath village maltlesham near ipswich, suffolk (excluding the highways) as the same is more particularly described in the equitable charge.
    Уполномоченные лица
    • F. J. Construction Limited
    Транзакции
    • 17 дек. 1984 г.Регистрация залога
    • 14 сент. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Equitable charge
    Создан 04 дек. 1984 г.
    Поставлен 07 дек. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a contract of even date
    Краткое описание
    Hamlet D.1 martlesham heath village martlesham near ipswich suffolk, (excluding the highways) as the same is more particularly described in the equitable charge.
    Уполномоченные лица
    • A.J.Gibbons & Son Limited
    Транзакции
    • 07 дек. 1984 г.Регистрация залога
    • 14 сент. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Equitable charge
    Создан 14 июн. 1984 г.
    Поставлен 16 июн. 1984 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a contract of even date
    Краткое описание
    Hamlet 'I' phase I martlesham heath village, martlesham, nr ipswich, suffolk.
    Уполномоченные лица
    • F. J. Construction Limited
    Транзакции
    • 16 июн. 1984 г.Регистрация залога
    • 14 сент. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 02 июн. 1982 г.
    Поставлен 21 июн. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a contract dated 2 june 82
    Краткое описание
    Hamlet 'j' martlesham heath village, martlesham nr ipswich suffolk.
    Уполномоченные лица
    • F. J. Construction Limited
    Транзакции
    • 21 июн. 1982 г.Регистрация залога
    • 14 сент. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage
    Создан 17 мар. 1981 г.
    Поставлен 25 мар. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 17.3.81.
    Краткое описание
    Hamlet e/2 martlesham heath village development suffolk.
    Уполномоченные лица
    • Haymills (Contractors) Limited
    Транзакции
    • 25 мар. 1981 г.Регистрация залога
    General equitable charge
    Создан 29 окт. 1980 г.
    Поставлен 18 нояб. 1980 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a contract dated 29.10.80.
    Краткое описание
    Hamlet B1, martlesham heath, martlesham, suffolk.
    Уполномоченные лица
    • F. J. Construction Limited.
    Транзакции
    • 18 нояб. 1980 г.Регистрация залога
    Mortgage
    Создан 14 дек. 1938 г.
    Приобретен 18 июн. 1991 г.
    Поставлен 14 дек. 1938 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £521-17-11 (owing)
    Краткое описание
    163 howards rd., Walthamstow.
    Уполномоченные лица
    • Halifax Building Society
    Транзакции
    • 14 дек. 1938 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0