WFG7 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииWFG7 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00261721
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель WFG7 LIMITED?

    • (9999) /

    Где находится WFG7 LIMITED?

    Юридический адрес
    50 Osmaston Road
    DE1 2HU Derby
    Derbyshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия WFG7 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    CINTIQUE LIMITED30 мар. 1989 г.30 мар. 1989 г.
    J.CINNAMON,LIMITED07 янв. 1932 г.07 янв. 1932 г.

    Каковы последние отчеты WFG7 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на03 окт. 2010 г.

    Какие последние документы подавались WFG7 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    3 страницы4.71

    Юридический адрес изменен с Estate Office Ravenstone Hall Ashby Road Ravenstone Leicestershire LE67 2AA England 11 янв. 2012 г.

    2 страницыAD01

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 03 янв. 2012 г.

    LRESSP

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital06 июл. 2011 г.

    Отчет о капитале на 06 июл. 2011 г.

    • Капитал: GBP 77,000
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    legacy

    6 страницыMG01

    legacy

    5 страницыMG01

    Юридический адрес изменен с Estate Office, Ravenstone Hall Ashby Road Ravenstone Coalville Leicestershire LE67 2AA United Kingdom 12 авг. 2010 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Изменение данных директора для Charles Colin Wade 01 окт. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с Gloucester House Wellington Street Long Eaton Nottingham NG10 4HT 21 июл. 2010 г.

    1 страницыAD01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    legacy

    9 страницыMG01

    legacy

    3 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    legacy

    3 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    legacy

    2 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    legacy

    7 страницы363s

    legacy

    7 страницы363s

    Кто является должностными лицами WFG7 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HIGTON, John Anthony
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant11338750001
    HIGTON, John Anthony
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant11338750001
    WADE, Charles Colin
    Osmaston Road
    DE1 2HU Derby
    50
    Derbyshire
    Директор
    Osmaston Road
    DE1 2HU Derby
    50
    Derbyshire
    EnglandBritishFurniture Manufacturer11338760002
    HIGTON, John Anthony
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Секретарь
    14 The Chancery
    Bramcote
    NG9 3AJ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector11338750001
    ROBSON, John Edward
    5 Park Wood
    BD23 1UY Skipton
    North Yorkshire
    Секретарь
    5 Park Wood
    BD23 1UY Skipton
    North Yorkshire
    Irish17401690002
    WILKS, Jeffrey Alan
    45 Norsey View Drive
    CM12 0QS Billericay
    Essex
    Секретарь
    45 Norsey View Drive
    CM12 0QS Billericay
    Essex
    BritishCompany Director34117860001
    BELLAMY, Alan Nicholas Fothergill
    50 Hawthorn Lane
    SK9 5DQ Wilmslow
    Cheshire
    Директор
    50 Hawthorn Lane
    SK9 5DQ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director11810320001
    BREWSTER, Andrew
    Danebury
    60 Ashford Road
    ME14 4LR Maidstone
    Kent
    Директор
    Danebury
    60 Ashford Road
    ME14 4LR Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director124693790001
    BURNETT, Christopher Thomas
    Flat 2 The Grange
    Harlow Oval
    HG2 0DS Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    Flat 2 The Grange
    Harlow Oval
    HG2 0DS Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director905440002
    GEMMELL, Graham Anthony
    Trecedars 24 Daws Mead
    Bishops Hull
    TA1 5HQ Taunton
    Somerset
    Директор
    Trecedars 24 Daws Mead
    Bishops Hull
    TA1 5HQ Taunton
    Somerset
    BritishCompany Director30277110001
    GOODWIN, Max
    13 York Fields
    BB18 5DA Barnoldswick
    Lancashire
    Директор
    13 York Fields
    BB18 5DA Barnoldswick
    Lancashire
    BritishCompany Director71947130001
    MALLINSON, Peter Neville
    16 Old Church Lane
    Westley
    IP33 3TJ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Директор
    16 Old Church Lane
    Westley
    IP33 3TJ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishDirector43408990002
    OSBORNE, Stephen John
    5 Garden Terrace
    Lothersdale
    BD20 8ER Keighley
    West Yorkshire
    Директор
    5 Garden Terrace
    Lothersdale
    BD20 8ER Keighley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director19140720002
    REES, Howard Thomas
    12 Hawfield Bank
    BR6 7TA Chelsfield
    Kent
    Директор
    12 Hawfield Bank
    BR6 7TA Chelsfield
    Kent
    BritishCompany Director52676100001
    ROBSON, John Edward
    5 Park Wood
    BD23 1UY Skipton
    North Yorkshire
    Директор
    5 Park Wood
    BD23 1UY Skipton
    North Yorkshire
    IrishCompany Director17401690002
    SOWDEN, Laurence James
    15 Darton Road
    Cawthorne
    S75 4HR Barnsley
    South Yorkshire
    Директор
    15 Darton Road
    Cawthorne
    S75 4HR Barnsley
    South Yorkshire
    BritishCompany Director71947040001
    SPENCER, Derek William
    44 Barrett Road
    Walthamstow
    E17 9ET London
    Директор
    44 Barrett Road
    Walthamstow
    E17 9ET London
    BritishCompany Director17420570001
    STUTTARD, James Nigel
    8 Buttercross Close
    BB11 5HB Burnley
    Lancashire
    Директор
    8 Buttercross Close
    BB11 5HB Burnley
    Lancashire
    BritishCompany Director51038230001
    UNTHANK, Derek Robert
    1 Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    Директор
    1 Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    BritishCompany Director17420550001
    VALINSKY, Michael
    71 Bush Hill Road
    Winchmore Hill
    N21 2DP London
    Директор
    71 Bush Hill Road
    Winchmore Hill
    N21 2DP London
    BritishCompany Director60972390001
    WILKS, Jeffrey Alan
    45 Norsey View Drive
    CM12 0QS Billericay
    Essex
    Директор
    45 Norsey View Drive
    CM12 0QS Billericay
    Essex
    BritishCompany Director34117860001

    Есть ли у WFG7 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Guarantee and floating charge
    Создан 04 апр. 2011 г.
    Поставлен 09 апр. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any of the other companies to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Floating charge over all assets meaning all undertaking property and assets rights and revenues present and future see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Christopher Charles Woodcock, the Trustee Corporation Limited Anna Catherine Proctor and Brian Andrew Winter
    Транзакции
    • 09 апр. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Guarantee and floating charge
    Создан 04 апр. 2011 г.
    Поставлен 09 апр. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any of the other companies to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Floating charge over all assets meaning all undertaking property and assets rights and revenues present and future see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Christopher Charles Woodcock, and the Trustee Corporation Limited
    Транзакции
    • 09 апр. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Guarantee and floating charge
    Создан 24 нояб. 2009 г.
    Поставлен 12 дек. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All the chargor's assets see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 дек. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    Intercreditor deed
    Создан 06 июл. 2000 г.
    Поставлен 13 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability (and any part thereof) of whatsoever kind and howsoever arising of the debtors or any one or more of them to the senior creditor from time to time including under or pursuant to or in respect of or in connection with the facility documents including the intercreditor deed or breach of any of the provisions thereof (the senior liabilities)
    Краткое описание
    "The deferred consideration" being the principal amount of the loan notes for the time being outstanding where the loan notes are defined as the guaranteed variable rate unsecured loan stock 2008 in a principal amount of £325,000 issued by the borrower.
    Уполномоченные лица
    • Singer & Friedlander
    Транзакции
    • 13 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 сент. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    All assets debenture
    Создан 16 мая 1997 г.
    Поставлен 04 июн. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Транзакции
    • 04 июн. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 16 мая 1997 г.
    Поставлен 31 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies obligations and liabilities on the part of the obligor to the chargee (the security trustee), the noteholders (as defined) and natwest ventures investments limited (together the beneficiaries) on any account whatsoever together with all expenses (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    Транзакции
    • 31 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 16 мая 1997 г.
    Поставлен 29 мая 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Firmback works andrews road hackney london t/no;-LN54011 & EGL169159 and connaught works old ford road tower hemlets london t/no;-416911. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 29 мая 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Chattel mortgage
    Создан 29 нояб. 1995 г.
    Поставлен 02 дек. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £200,000.000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Краткое описание
    Motor cars:- mercedes 190E reg march 91, reg number - H903VGX. Audi coupe auto 2.3E reg dec 90, reg number - H409 bmk. Vauxhall cavalier 2.0 gli reg aug 91, reg numnber - J632 tsf.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 02 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Third party trust debenture
    Создан 31 авг. 1990 г.
    Поставлен 14 сент. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from moorfield holdings limited to nat west investment bank limited as trustees for the beneficiaries (as defined) under the terms of the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    Please see form 395 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Nat West Investment Bank Limited
    Транзакции
    • 14 сент. 1990 г.Регистрация залога
    • 05 июл. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 03 нояб. 1981 г.
    Поставлен 06 нояб. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H connaught warks old ford road, poplar london E8 T.N. 416911.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank LTD
    Транзакции
    • 06 нояб. 1981 г.Регистрация залога
    Deposit of deeds
    Создан 15 янв. 1947 г.
    Поставлен 03 февр. 1947 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due etc.
    Краткое описание
    39/42 andrews rd hackney E8.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank LTD
    Транзакции
    • 03 февр. 1947 г.Регистрация залога

    Есть ли у WFG7 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    04 окт. 2012 г.Дата ликвидации
    03 янв. 2012 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    John Allen
    50 Osmaston Road
    DE1 2HU Derby
    Derbyshire
    Практик
    50 Osmaston Road
    DE1 2HU Derby
    Derbyshire

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0