00330983 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компании00330983 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00330983
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель 00330983 LIMITED?

    • Прочие профессиональные, научные и технические услуги, не включенные в другие группировки (74909) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится 00330983 LIMITED?

    Юридический адрес
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия 00330983 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    ENERGY CONVERSION LIMITED26 мар. 1991 г.26 мар. 1991 г.
    CHLORIDE INDUSTRIAL BATTERIES LIMITED31 дек. 1978 г.31 дек. 1978 г.
    ELECTRIC POWER STORAGE LIMITED24 авг. 1937 г.24 авг. 1937 г.

    Каковы последние отчеты 00330983 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2012 г.

    Какие последние документы подавались 00330983 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Восстановление по решению суда

    4 страницыAC92

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed viper security\certificate issued on 20/05/19
    страницыCERTNM

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital17 февр. 2014 г.

    Отчет о капитале на 17 февр. 2014 г.

    • Капитал: GBP 1
    SH01

    Назначение Mr David Anthony Noonan на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Jeffrey Young в качестве директора

    1 страницыTM01

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Conflict of interest 29/08/2013
    RES13

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 14 мая 2013 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Cancel £28571000 from share prem a/c 08/05/2013
    RES13

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    14 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Прекращение полномочий Ian Bray в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Anton Conrad на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Jeffrey John Young на должность директора

    2 страницыAP01

    Разное

    Aud res
    1 страницыMISC

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Назначение Teresa Field на должность секретаря

    3 страницыAP03

    Кто является должностными лицами 00330983 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    FIELD, Teresa
    Baker Street
    W1U 7AL London
    44
    Секретарь
    Baker Street
    W1U 7AL London
    44
    British157526820001
    CONRAD, Anton
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    Директор
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    United KingdomGermanLegal Counsel164961320001
    NOONAN, David Anthony
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    Директор
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    EnglandBritishVice President Finance134531200003
    CLAPHAM, Colin Richard
    The Homestead
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Essex
    Секретарь
    The Homestead
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Essex
    British9684390001
    MESSENT, Jon
    Singlets Lane
    Flamstead
    AL3 8EP St Albans
    6
    Hertfordshire
    Секретарь
    Singlets Lane
    Flamstead
    AL3 8EP St Albans
    6
    Hertfordshire
    BritishSolicitor157179420001
    WILLIAMS, Susan
    Flat 3
    51 Harley Street
    W1G 8QQ London
    Секретарь
    Flat 3
    51 Harley Street
    W1G 8QQ London
    British83126720001
    BRAY, Ian Alexander
    57 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Директор
    57 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Executive78956770001
    CLAPHAM, Colin Richard
    The Homestead
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Essex
    Директор
    The Homestead
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAsst Company Secreta9684390001
    MESSENT, Jon
    Singlets Lane
    Flamstead
    AL3 8EP St Albans
    6
    Hertfordshire
    Директор
    Singlets Lane
    Flamstead
    AL3 8EP St Albans
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor157179420001
    VASS, Michael Leslie
    Melrose 14 Orchard Close
    Copford
    CO6 1DB Colchester
    Essex
    Директор
    Melrose 14 Orchard Close
    Copford
    CO6 1DB Colchester
    Essex
    BritishFinancial Director9725330001
    WILLIAMS, Susan
    Flat 3
    51 Harley Street
    W1G 8QQ London
    Директор
    Flat 3
    51 Harley Street
    W1G 8QQ London
    BritishSolicitor83126720001
    WRIGHT, David John
    45 Picton Way
    Caversham
    RG4 8NJ Reading
    Berkshire
    Директор
    45 Picton Way
    Caversham
    RG4 8NJ Reading
    Berkshire
    BritishCompany Secretary9725340001
    YOUNG, Jeffrey John
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    Директор
    Ebury Gate
    23 Lower Belgrave Street
    SW1W 0NR London
    United KingdomBritishVp & Controller164961580001

    Есть ли у 00330983 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Fixed and floating charge
    Создан 13 дек. 1994 г.
    Поставлен 30 дек. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hill Samuel Bank Limited
    Транзакции
    • 30 дек. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating charge
    Создан 13 дек. 1994 г.
    Поставлен 21 дек. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мар. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Second supplemental deed
    Создан 11 нояб. 1992 г.
    Поставлен 01 дек. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the relevant documents as defined
    Краткое описание
    See form 395 ref M127. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hill Samuel Bank Limited
    Транзакции
    • 01 дек. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мар. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental security deed
    Создан 26 мар. 1991 г.
    Поставлен 11 апр. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from chloride group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the security deed and the facility letters as defined in this deed
    Краткое описание
    All the assets and property (see doc M858C for full details).
    Уполномоченные лица
    • Hill Samuel Bank Limited
    Транзакции
    • 11 апр. 1991 г.Регистрация залога
    • 01 мар. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security deed
    Создан 20 июл. 1990 г.
    Поставлен 07 авг. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the security documents (as defined) and a facility letter dated 20/07/90 having available a loan facility of up to us$6,000,000 on any account whatsoever
    Краткое описание
    (See form 395 ref M518C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Gota Bank (London Branch)
    Транзакции
    • 07 авг. 1990 г.Регистрация залога
    • 01 мар. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security deed
    Создан 20 июл. 1990 г.
    Поставлен 07 авг. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Us $25,500,000 and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in respect of a secured revolving credit facility agreement dated 20/7/90 and the security documents (as defined) a deed of priorities dated 20/7/90 and this security deed
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Hill Samuel Bank Limited
    Транзакции
    • 07 авг. 1990 г.Регистрация залога
    • 11 мая 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 08 июл. 1987 г.
    Поставлен 23 июл. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and standard chartered bank on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 23 июл. 1987 г.Регистрация залога
    • 01 мар. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of substitution
    Создан 30 апр. 1987 г.
    Поставлен 19 мая 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £5,000,000 7 1/8% first mortgage debenture stock 1985/90 of chloride group PLC due from the company to the commercial union assurance company PLC secured by a trust deed dated 21.7.85 and a supplemental deed dated 29.3.83
    Краткое описание
    F/H land to the north of rake lane clifton junction swinton, greater manchester f/h land situate to north of rake lane aforesaid t/no: la 312077 all buildings, erections, fixed plant fixed machinery, fixtures (see 395).
    Уполномоченные лица
    • Commercial Union Assurance Company PLC
    Транзакции
    • 19 мая 1987 г.Регистрация залога
    • 11 мая 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed of accession
    Создан 12 дек. 1985 г.
    Поставлен 20 дек. 1985 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as the agent on any account whatsoever and supplemental to the debenture of 29 sep 1982
    Краткое описание
    (See doc M152 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Agent Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 20 дек. 1985 г.Регистрация залога
    Supplemental trust deed
    Создан 29 мар. 1983 г.
    Поставлен 18 апр. 1983 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £5,000,000 7 1/8% first mortgage debenture stock 1985/90 of chloride group PLC secured by a trust deed 21/7/65 & deeds supplemental thereto
    Краткое описание
    Land at wynne ave clifton, swinton manchester tn gm 118460 land and buildings on the south west side of salford rd tn la 242450.
    Уполномоченные лица
    • Commercial Union Assurance Company PLC
    Транзакции
    • 18 апр. 1983 г.Регистрация залога
    • 11 мая 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession
    Создан 02 мар. 1983 г.
    Поставлен 15 мар. 1983 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to lloyds bank PLC as agent
    Краткое описание
    (See doc M149 for furtehr detials). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank Plcas Agent
    Транзакции
    • 15 мар. 1983 г.Регистрация залога
    Omnibus debenture
    Создан 29 сент. 1982 г.
    Поставлен 05 окт. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to chloride group PLC
    Краткое описание
    All the undertaking property and assets of the company both present and future.
    Уполномоченные лица
    • Chloride Group PLC
    Транзакции
    • 05 окт. 1982 г.Регистрация залога
    Omnibus debenture
    Создан 29 сент. 1982 г.
    Поставлен 05 окт. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 05 окт. 1982 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0