RYBAR LABORATORIES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииRYBAR LABORATORIES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00366644
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    • Неторговая компания неторговая (74990) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    1 страницыDS01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 июн. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Изменение данных секретаря

    1 страницыCH04

    Изменение данных секретаря для Shire Corporate Services Limited 28 апр. 2020 г.

    1 страницыCH04

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 июн. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Mrs Sarah Lucy Charsley на должность директора 28 февр. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Stephen Philip Williams в качестве директора 08 февр. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Kentaro Shirahata на должность директора 31 дек. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Helen Alice Lillistone в качестве директора 31 дек. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Прекращение полномочий Jonathan Ivan William Webb в качестве директора 30 июн. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 июн. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Shire Corporate Services Limited на должность секретаря 01 мар. 2018 г.

    2 страницыAP04

    Прекращение полномочий Oliver Strawbridge в качестве секретаря 01 мар. 2018 г.

    1 страницыTM02

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Регистры перемещены по юридическому адресу 1 Kingdom Street London W2 6BD

    1 страницыAD04

    Юридический адрес изменен с Hampshire International Business Park Chineham Basingstoke Hampshire RG24 8EP на 1 Kingdom Street London W2 6BD 03 июл. 2017 г.

    1 страницыAD01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 июн. 2017 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Уведомление о Shire Pharmaceuticals Group как лице, осуществляющем значительный контроль, 06 апр. 2016 г.

    2 страницыPSC02

    Назначение Mr Stephen Philip Williams на должность директора 05 апр. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Jonathan Ivan William Webb на должность директора 05 апр. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Amanda Miller в качестве директора 20 февр. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер11022500
    244206590002
    CHARSLEY, Sarah Lucy
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssistant Company Secretary239205090001
    SHIRAHATA, Kentaro
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomJapaneseAccountant248114700001
    GUTHRIE, Anthony James
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    Секретарь
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    British131668010002
    HARRIS, Neil Charles
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    Секретарь
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    BritishLegal Adviser96188470001
    LEVIN, Ronald
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD23 1DU Watford
    Hertfordshire
    Секретарь
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD23 1DU Watford
    Hertfordshire
    British2760720001
    MAY, Tatjana Anni Hilde
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Секретарь
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    BritishLawyer75855670003
    MCLEAN, Andrew Firth
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    Секретарь
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    British55993260003
    RUSSELL, Angus Charles
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Секретарь
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British52943380002
    STEPHENS, Dennis John
    24 Silver Drive
    GU16 5QR Camberley
    Surrey
    Секретарь
    24 Silver Drive
    GU16 5QR Camberley
    Surrey
    BritishDirector/Company Secretary21180020002
    STRAWBRIDGE, Oliver
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Секретарь
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    202187490001
    BOWLING, James Nicholas
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant178036960001
    CLARKE, Janet
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant14380770001
    DAVIS, Trevor
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    Директор
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    United KingdomBritishDirector37725830001
    EMMENS, Matthew William
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    AmericanDirector88969740002
    FLETCHER, John Allan
    The Coach House
    58 Cambridge Road West
    GU14 6QA Farnborough
    Hampshire
    Директор
    The Coach House
    58 Cambridge Road West
    GU14 6QA Farnborough
    Hampshire
    BritishCompany Director21180050001
    HARTLEY, Daniel William David
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomAustralianCompany Director184526870001
    LEVIN, Andrew Paul
    44 Carmel Court
    Wembley Park
    HA9 9JF Wembley
    Middlesex
    Директор
    44 Carmel Court
    Wembley Park
    HA9 9JF Wembley
    Middlesex
    BritishBarrister25919670001
    LEVIN, Diane Kate
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD2 1DU Watford
    Hertfordshire
    Директор
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD2 1DU Watford
    Hertfordshire
    BritishBuyer5220440001
    LEVIN, Ronald
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD23 1DU Watford
    Hertfordshire
    Директор
    3 Haydon Hill House
    Bushey
    WD23 1DU Watford
    Hertfordshire
    BritishPharmacist2760720001
    LILLISTONE, Helen Alice
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director132989360002
    LUCAS, Richard
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant186523080001
    MCPARTLAND, Peter
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    Директор
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    EnglandBritishVenture Capitalist155226180001
    MILLER, Amanda
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor186523040021
    NIELSON, Kaj George
    Aaskiltegaard
    O/Estby 40/50 Skibby
    FOREIGN
    Denmark
    Директор
    Aaskiltegaard
    O/Estby 40/50 Skibby
    FOREIGN
    Denmark
    DanishIndependent Pharmaceutcal Consultant7433460001
    RUS, Joseph
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    Директор
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    CanadianHead Of Sales & Marketing Inte95909400001
    RUSSELL, Angus Charles
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Директор
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishFinancial Accountant52943380004
    STAHEL, Rolf
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    Директор
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    United KingdomSwissChairman41392130001
    STRATFORD, Harry Thomas
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    Директор
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritishDirector125826470001
    TRINDADE MENEZES ESOUZA, Richard Anthony Joseph
    1 Copperfields
    Caversham Heights
    RG4 7PQ Reading
    Berkshire
    Директор
    1 Copperfields
    Caversham Heights
    RG4 7PQ Reading
    Berkshire
    BritishDirector74101570002
    WEBB, Jonathan Ivan William
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant220802930001
    WILLIAMS, Stephen Philip
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Директор
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary232177850001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над RYBAR LABORATORIES LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Shire Pharmaceuticals Group
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    1 Kingdom Street
    England
    06 апр. 2016 г.
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    1 Kingdom Street
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаUnlimited With Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер2883758
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у RYBAR LABORATORIES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 23 дек. 1999 г.
    Поставлен 06 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Dlj Capital Funding Inc.
    Транзакции
    • 06 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 янв. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 19 дек. 1994 г.
    Поставлен 05 янв. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from shire pharmaceutical development limited ("spdl") to the noteholders in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes 1995 of spdl originally constituted by the deed poll of spdl dated 19 december 1994 or under the terms of the loan note instrument and all monies incurred by the instructing group (as defined in the debenture) or by the noteholders or by any receiver in connection with the deed or in respect of the assets and all monies secured by clause 7 of the loan note instrument or by the provisions of the additional security documentation
    Краткое описание
    Fixed charge over :- 1) all copyrights patents, trade marks, service marks, registered designs, design rights etc. 2) all book debts and other debts claims ans sums which are or will in the future become payable or owed to the company and the benefit of all rights relating thereto. 3) all stocks, shares, bonds, warrants, units and securities of any kind. 4) all f/h and l/h property. Floating charge over :- all the undertaking assets and property of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Noteholders
    Транзакции
    • 05 янв. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 авг. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 01 июн. 1982 г.
    Поставлен 21 июн. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 21 июн. 1982 г.Регистрация залога
    • 02 дек. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 22 дек. 1980 г.
    Поставлен 02 янв. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including B3OKDEBTS uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 02 янв. 1981 г.Регистрация залога
    • 02 дек. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0