GORSEY SIX LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGORSEY SIX LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00421037
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GORSEY SIX LIMITED?

    • (5212) /

    Где находится GORSEY SIX LIMITED?

    Юридический адрес
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GORSEY SIX LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    ECLIPSE BLINDS LIMITED14 июл. 1994 г.14 июл. 1994 г.
    ASHLEY GROUP PLC09 сент. 1988 г.09 сент. 1988 г.
    ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C31 дек. 1979 г.31 дек. 1979 г.
    THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED07 окт. 1946 г.07 окт. 1946 г.

    Каковы последние отчеты GORSEY SIX LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2005 г.

    Какие последние документы подавались GORSEY SIX LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    3 страницы4.71

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 07 июн. 2010 г.

    5 страницы4.68

    Юридический адрес изменен с Kpmg Restructuring 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL 22 дек. 2009 г.

    1 страницыAD01

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 07 дек. 2009 г.

    5 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 07 июн. 2009 г.

    5 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 07 дек. 2008 г.

    5 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 07 дек. 2008 г.

    5 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах

    5 страницы4.68

    legacy

    1 страницы287

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации

    LRESSP

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    legacy

    2 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    legacy

    3 страницы363s

    legacy

    1 страницы288c

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    legacy

    7 страницы363s

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    7 страницы363s

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02
    2 страницыCERTNM

    Кто является должностными лицами GORSEY SIX LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    Секретарь
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    British9962100001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    Директор
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish28937370012
    WILSON, Stephen Graham
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    Директор
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish23638320002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Секретарь
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    GILLIES, Malcolm John
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    Секретарь
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    British1381960001
    STABLES, Jane Margaret
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    Секретарь
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    British41059230001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    Директор
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    British57834870001
    BLACK, James Edward
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    Директор
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    ScotlandUnited Kingdom35816690001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Директор
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    BUTLER, Anthony Bertram
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    Директор
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    British18439630001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Директор
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Директор
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    JOHN, Christopher
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    Директор
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    British71834620003
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    British34964530002
    LANGLANDS, John Thomson
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    Директор
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    ScotlandBritish722090001
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Директор
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritish10878930001
    MACDONALD, William
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    Директор
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    British539830001
    MAYDON, Peter John
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    Директор
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish5988360001
    MCNEIL, Robert
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    Директор
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish31415950001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Директор
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MONSERRAT MESANZA, Miguel
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Директор
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945210001
    ORTON, Anthony Stanley
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    Директор
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    British Canadian12605660001
    RODGER, James Roy
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Директор
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British48535040002
    THOMAS, John Alan
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    Директор
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    British802790001
    TIPPER, Christopher Stuart
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    Директор
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    British46918370001
    URCELAY ALONSO, Antonio
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Директор
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945230001
    WHITE, James
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    Директор
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    British28464050001

    Есть ли у GORSEY SIX LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Floating charge
    Создан 29 нояб. 1995 г.
    Поставлен 08 дек. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Undertaking and all property and assets.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 08 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 февр. 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 29 нояб. 1995 г.
    Поставлен 02 дек. 1995 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 02 дек. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    A deed of charge
    Создан 30 июн. 1994 г.
    Поставлен 18 июл. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994
    Краткое описание
    (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • James Mcneil
    Транзакции
    • 18 июл. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of charge
    Создан 30 июн. 1994 г.
    Поставлен 18 июл. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Краткое описание
    The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • James Mcneil
    Транзакции
    • 18 июл. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of charge
    Создан 30 июн. 1994 г.
    Поставлен 18 июл. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Краткое описание
    All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Robert Mcneil
    Транзакции
    • 18 июл. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of charge
    Создан 30 июн. 1994 г.
    Поставлен 18 июл. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Краткое описание
    By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Robert Mcneil
    Транзакции
    • 18 июл. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 03 сент. 1993 г.
    Поставлен 10 сент. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge
    Краткое описание
    By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395).
    Уполномоченные лица
    • Secured Parties (As Defined).
    Транзакции
    • 10 сент. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 дек. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment agreement
    Создан 31 авг. 1988 г.
    Поставлен 05 сент. 1988 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment
    Краткое описание
    All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50).
    Уполномоченные лица
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Транзакции
    • 05 сент. 1988 г.Регистрация залога
    Debenture
    Создан 31 авг. 1988 г.
    Поставлен 05 сент. 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge
    Краткое описание
    (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Транзакции
    • 05 сент. 1988 г.Регистрация залога
    • 12 мар. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у GORSEY SIX LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    17 нояб. 2010 г.Дата ликвидации
    08 дек. 2006 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Практик
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Практик
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0