ENODIS INVESTMENTS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииENODIS INVESTMENTS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00455541
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Юридический адрес
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BERISFORD INVESTMENTS LIMITED05 дек. 1996 г.05 дек. 1996 г.
    BERISFORD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED26 сент. 1991 г.26 сент. 1991 г.
    BERISFORD (CREDIT RESOURCES) LIMITED11 июн. 1987 г.11 июн. 1987 г.
    J.H. RAYNER (HOLDINGS) LIMITED25 мар. 1983 г.25 мар. 1983 г.
    ZWANENBERG ASSOCIATED FOOD COMPANIES LIMITED15 июн. 1948 г.15 июн. 1948 г.

    Каковы последние отчеты ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2020 г.

    Какие последние документы подавались ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    1 страницыDS01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    13 страницыAA

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    legacy

    36 страницыPARENT_ACC

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    13 страницыAA

    legacy

    28 страницыPARENT_ACC

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    Уведомление о подтверждении, составленное 12 янв. 2021 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Назначение Esyllt John-Featherby на должность директора 19 июн. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий John Albert James Rourke в качестве директора 19 июн. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Enodis Property Group Limited как лица, осуществляющего значительный контроль, 27 февр. 2020 г.

    1 страницыPSC07

    Изменение данных о Enodis Group Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 27 февр. 2020 г.

    2 страницыPSC05

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 27 февр. 2020 г.

    • Капитал: GBP 0.50
    3 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    6 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Уведомление о подтверждении, составленное 12 янв. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    12 страницыAA

    legacy

    32 страницыPARENT_ACC

    legacy

    1 страницыAGREEMENT2

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    Кто является должностными лицами ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Секретарь компании
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Директор
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritishAccountant146072380001
    JOHN-FEATHERBY, Esyllt
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Директор
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    EnglandBritishVp Finance Emea273323780001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Директор
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritishAccountant79449700002
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    Директор
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritishChief Executive33301630002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Директор
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCorporate Treasurer6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Директор
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United StatesSolicitor134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Директор
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishFinance Director45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Директор
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritishChartered Accountant61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Директор
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary17023730002
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Директор
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmericanCompany Director134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Директор
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanCompany Director136570610001
    LEE, Paul Allan
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    Директор
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    EnglandBritishDirector Of Corporate Control70564410001
    MITCHELL, Graham Ramsay
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    Директор
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    EnglandBritishChartered Accountant105501360001
    NOBLE, Andrew Villiers
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    Директор
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    BritishProperty Director64593020001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Номинированный директор
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    ROURKE, John Albert James
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Директор
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United KingdomBritishCompany Director77646900002
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Директор
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director43215170003
    WINTON, Adam Howard
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    Директор
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    EnglandBritishChartered Surveyor50077250001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Директор компании
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Директор компании
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 апр. 2016 г.
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Да
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер2629464
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.
    Enodis Group Limited
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 апр. 2016 г.
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииCompanies House
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииEngland
    Регистрационный номер4330202
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у ENODIS INVESTMENTS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Создан 11 апр. 2002 г.
    Поставлен 25 апр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Транзакции
    • 25 апр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Создан 20 февр. 2002 г.
    Поставлен 08 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Транзакции
    • 08 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Создан 22 нояб. 2001 г.
    Поставлен 30 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 16 сент. 1993 г.
    Поставлен 20 сент. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each of the indebtedness agreements (as defined)
    Краткое описание
    The f/h property k/a bredbury industrial park stockport t/n gm 625224. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 сент. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of amendment
    Создан 01 нояб. 1991 г.
    Поставлен 15 нояб. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (the security agent) and the banks or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 15 нояб. 1991 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 окт. 1991 г.
    Поставлен 14 окт. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee (the second security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from the company under the subordinated guarantee and under the terms of the charge
    Краткое описание
    All that f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 - see form 395 for further details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 14 окт. 1991 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 окт. 1991 г.
    Поставлен 14 окт. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due form each obligor (as defined therein) to the chargee (the security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Краткое описание
    All f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 and all f/h land k/a 3 and 4 the square, petersfield, hampshire - see form 395 for further details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 14 окт. 1991 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 30 июл. 1991 г.
    Приобретен 31 янв. 1992 г.
    Поставлен 11 февр. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Краткое описание
    Units 51, 52, 53, 54, 56 and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kenttitle number: K608279.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 11 февр. 1992 г.Регистрация приобретения (400)
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 30 июл. 1991 г.
    Приобретен 31 янв. 1992 г.
    Поставлен 11 февр. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Краткое описание
    Units 51, 52, 53, 54, 56, and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kent title number: K608279.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 11 февр. 1992 г.Регистрация приобретения (400)
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 26 сент. 1990 г.
    Поставлен 09 окт. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the second security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berksford international PLC under the subordinated guarantee
    Краткое описание
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 окт. 1990 г.Регистрация залога
    • 30 янв. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 сент. 1990 г.
    Поставлен 09 окт. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Краткое описание
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 окт. 1990 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 09 февр. 1990 г.
    Приобретен 30 сент. 1991 г.
    Поставлен 21 окт. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies
    Краткое описание
    13 lower bristol road, avon bath title no av 190171.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 окт. 1991 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 15 июл. 1988 г.
    Приобретен 30 сент. 1991 г.
    Поставлен 21 окт. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies
    Краткое описание
    Land on the north & south side of lower bristol road bath, avon title no av 92613.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 21 окт. 1991 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0