EP PACKAGING LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииEP PACKAGING LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00516832
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель EP PACKAGING LIMITED?

    • (2522) /

    Где находится EP PACKAGING LIMITED?

    Юридический адрес
    Beaufort House 94-96 Newhall Street
    B3 1PB Birmingham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия EP PACKAGING LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    LOWFIELD SECURITIES LIMITED15 мая 1984 г.15 мая 1984 г.
    LOWFIELD LIMITED31 дек. 1979 г.31 дек. 1979 г.
    ARTHUR WOOLLACOTT LIMITED07 мар. 1953 г.07 мар. 1953 г.

    Каковы последние отчеты EP PACKAGING LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2006 г.

    Какие последние документы подавались EP PACKAGING LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    3 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 23 авг. 2010 г.

    5 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 23 февр. 2010 г.

    5 страницы4.68

    Регистрация банкротства

    INSOLVENCY:sos cert release of liquidator
    1 страницыLIQ MISC

    Уведомление о прекращении деятельности в качестве добровольного ликвидатора

    1 страницы4.40

    Решение суда по делу о банкротстве

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    30 страницыLIQ MISC OC

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    7 страницы2.34B

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    4 страницы2.16B

    Результат собрания кредиторов

    2 страницы2.23B

    Заявление о предложениях администратора

    29 страницы2.17B

    legacy

    1 страницы287

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    legacy

    1 страницы288a

    Бухгалтерская отчетность для среднего предприятия

    17 страницыAA

    legacy

    2 страницы363a

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    1 страницы288c

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    3 страницы395

    legacy

    2 страницы403a

    Кто является должностными лицами EP PACKAGING LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    THOMAS, Emma Jane
    27 Hanbury Green
    Shobdon
    HR6 9NS Leominster
    Herefordshire
    Секретарь
    27 Hanbury Green
    Shobdon
    HR6 9NS Leominster
    Herefordshire
    British123204420001
    MONDON, Peter Nigel
    Keepers Cottage
    Colemore Green
    WV16 4ST Bridgnorth
    Shropshire
    Директор
    Keepers Cottage
    Colemore Green
    WV16 4ST Bridgnorth
    Shropshire
    EnglandBritish51801010002
    RODEN, John Philip Edward
    10 Epsom Way
    LL13 0LZ Wrexham
    Clwyd
    Директор
    10 Epsom Way
    LL13 0LZ Wrexham
    Clwyd
    WalesBritish126776380001
    SIMMONS, Timothy
    4 Malthouse Close
    Whittington
    SY11 4NA Oswestry
    Salop
    Директор
    4 Malthouse Close
    Whittington
    SY11 4NA Oswestry
    Salop
    British111681270001
    FARR, Geoffrey
    2 Old Rectory Gardens
    West Felton
    SY11 4QE Oswestry
    Shropshire
    Секретарь
    2 Old Rectory Gardens
    West Felton
    SY11 4QE Oswestry
    Shropshire
    British76875660003
    HAISELDEN, Alan William
    Tatters End
    6 Grange Close
    TN6 1YD Crowborough
    East Sussex
    Секретарь
    Tatters End
    6 Grange Close
    TN6 1YD Crowborough
    East Sussex
    British1608740001
    KARA, Peter Bhupatsingh
    73 Windmill Hill Drive
    Bletchley
    MK3 7RJ Milton Keynes
    Секретарь
    73 Windmill Hill Drive
    Bletchley
    MK3 7RJ Milton Keynes
    British1575610001
    MONDON, Peter Nigel
    Keepers Cottage
    Colemore Green
    WV16 4ST Bridgnorth
    Shropshire
    Секретарь
    Keepers Cottage
    Colemore Green
    WV16 4ST Bridgnorth
    Shropshire
    British51801010002
    BALDWIN, Keith
    15 Green Park
    LL13 8YE Wrexham
    Clwyd
    Директор
    15 Green Park
    LL13 8YE Wrexham
    Clwyd
    British41150700001
    CHEESEMAN, John Jeffrey
    31 Haven Close
    BR8 7JY Swanley
    Kent
    Директор
    31 Haven Close
    BR8 7JY Swanley
    Kent
    British40922460001
    FRANKLIN, Grant Roger
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    Директор
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    British4876290002
    GAWNE, Christopher William
    The Coach House Allerton Hill
    Westwood Road
    GU20 6LS Windlesham
    Surrey
    Директор
    The Coach House Allerton Hill
    Westwood Road
    GU20 6LS Windlesham
    Surrey
    British32263200001
    HAISELDEN, Alan William
    Tatters End
    6 Grange Close
    TN6 1YD Crowborough
    East Sussex
    Директор
    Tatters End
    6 Grange Close
    TN6 1YD Crowborough
    East Sussex
    British1608740001
    HARRAGE, Christopher
    11 Meadowcroft
    Cross Lanes
    LL13 0UJ Wrexham
    Clwyd
    Директор
    11 Meadowcroft
    Cross Lanes
    LL13 0UJ Wrexham
    Clwyd
    British41150780001
    KARA, Peter Bhupatsingh
    73 Windmill Hill Drive
    Bletchley
    MK3 7RJ Milton Keynes
    Директор
    73 Windmill Hill Drive
    Bletchley
    MK3 7RJ Milton Keynes
    EnglandBritish1575610001
    MITCHELL, Neil James
    7 Grange Court
    Cross Lanes
    LL13 0SX Wrexham
    Clwyd
    Директор
    7 Grange Court
    Cross Lanes
    LL13 0SX Wrexham
    Clwyd
    British104634730001
    MULLANEY, Stuart David
    Wayside
    Laurels Avenue
    LL13 0BB Bangor On Dee
    Wrexham
    Директор
    Wayside
    Laurels Avenue
    LL13 0BB Bangor On Dee
    Wrexham
    British81819120001
    PRETZLIK, Nicholas Charles
    44 Hornton Street
    W8 4NT London
    Директор
    44 Hornton Street
    W8 4NT London
    British1575620001
    STEEL, Robert Emmanual
    8 Hinchley Close
    Hartford
    CW8 1SU Northwich
    Cheshire
    Директор
    8 Hinchley Close
    Hartford
    CW8 1SU Northwich
    Cheshire
    British37091130003
    THOMPSON, Ronald Arthur
    Redriff
    44 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    Директор
    Redriff
    44 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish1575630001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Директор
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    British17203000001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Директор
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    British17203000001

    Есть ли у EP PACKAGING LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 16 нояб. 2006 г.
    Поставлен 18 нояб. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Redbrick Estates Limited
    Транзакции
    • 18 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Fixed and floating charge
    Создан 15 дек. 2002 г.
    Поставлен 03 янв. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Транзакции
    • 03 янв. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Fixed charge
    Создан 19 окт. 1998 г.
    Поставлен 21 окт. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The principal sum of £102,000.00 together with interest due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    A first fixed charge over 1 x GN3021C high speed pressure former machines s/n 81171706525.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 21 окт. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 нояб. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed charge
    Создан 17 апр. 1998 г.
    Поставлен 21 апр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £32,393 due from the company to the chargee
    Краткое описание
    Fixed charge over: 1 x ecoair rotary screw air compressor plus accessories including EAA600F filter s/n 2420118.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Транзакции
    • 21 апр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 нояб. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 12 сент. 1994 г.
    Поставлен 29 сент. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,000,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H property k/a unit 2 challenge road ashford feltham middlesex title no NGL529671.
    Уполномоченные лица
    • Arthur Woollacott Limited
    Транзакции
    • 29 сент. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 28 янв. 1991 г.
    Поставлен 06 февр. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and building at queensway industrial estate queensway wrexham t/n wa 501074 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 06 февр. 1991 г.Регистрация залога
    • 20 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 02 нояб. 1990 г.
    Поставлен 07 нояб. 1990 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 07 нояб. 1990 г.Регистрация залога

    Есть ли у EP PACKAGING LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    20 июн. 2008 г.Начало управления
    24 февр. 2009 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Colin Andrew Prescott
    Moore Stephens
    Corporate Recovery
    B3 1PB Beaufort House
    94-96 Newhall Street Birmingham
    Практик
    Moore Stephens
    Corporate Recovery
    B3 1PB Beaufort House
    94-96 Newhall Street Birmingham
    Nigel Price
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    Практик
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    2
    ДатаТип
    24 февр. 2009 г.Начало ликвидации
    21 апр. 2011 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Nigel Price
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    Практик
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    David Alan Rolph
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Практик
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Phillip Rodney Sykes
    1-3 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Практик
    1-3 Snow Hill
    EC1A 2DH London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0