TERMINUS 20 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTERMINUS 20 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00522014
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TERMINUS 20 LIMITED?

    • (2222) /

    Где находится TERMINUS 20 LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия TERMINUS 20 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    POLESTAR SPECIALIST COLOUR LIMITED06 нояб. 1998 г.06 нояб. 1998 г.
    BPC DUNSTABLE LTD31 окт. 1996 г.31 окт. 1996 г.
    BPC MAGAZINES (DUNSTABLE) LTD23 нояб. 1995 г.23 нояб. 1995 г.
    BPC WATERLOW LTD18 янв. 1994 г.18 янв. 1994 г.
    BPCC WATERLOW LTD13 мар. 1991 г.13 мар. 1991 г.
    BPCC OYEZ WATERLOW DUNSTABLE LTD.24 янв. 1990 г.24 янв. 1990 г.
    BPCC WATERLOW LTD04 мая 1989 г.04 мая 1989 г.
    WATERLOW LIMITED31 дек. 1981 г.31 дек. 1981 г.
    WATERLOW (DUNSTABLE) LIMITED21 июл. 1953 г.21 июл. 1953 г.

    Каковы последние отчеты TERMINUS 20 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2009 г.

    Какие последние документы подавались TERMINUS 20 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed polestar specialist colour LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    5 страницыCERTNM
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 окт. 2010 г.

    Отчет о капитале на 20 окт. 2010 г.

    • Капитал: GBP 53,899
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Изменение данных секретаря для Alan Goodwin 31 июл. 2009 г.

    1 страницыCH03

    Изменение данных директора для Alan Goodwin 31 июл. 2009 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерская отчетность

    8 страницыAA

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    legacy

    4 страницы363a

    Бухгалтерская отчетность

    8 страницыAA

    legacy

    1 страницы287

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    3 страницы363a

    legacy

    1 страницы288b

    Бухгалтерская отчетность

    8 страницыAA

    Решения

    Resolutions
    4 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    legacy

    3 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    legacy

    1 страницы225

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Кто является должностными лицами TERMINUS 20 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Секретарь
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    British98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Директор
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritish98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Директор
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Директор
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Директор
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritish138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Секретарь
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Директор
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Директор
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British16105360002
    DAVIDGE, John David
    Little Thatch
    Park Lane
    MK44 1LF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Директор
    Little Thatch
    Park Lane
    MK44 1LF Sharnbrook
    Bedfordshire
    British30567520001
    DICKSON, Peter Heron
    The Old Bakery
    Lower Way, Padbury
    MK18 2AX Buckingham
    Buckinghamshire
    Директор
    The Old Bakery
    Lower Way, Padbury
    MK18 2AX Buckingham
    Buckinghamshire
    British66484940001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Директор
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Директор
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    British83714120001
    MOUSLEY, Richard Mark
    2 Marlborough Place
    Toddington
    LU5 6BU Dunstable
    Bedfordshire
    Директор
    2 Marlborough Place
    Toddington
    LU5 6BU Dunstable
    Bedfordshire
    British50489630001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Директор
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Директор
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritish44908110001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Директор
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritish127238050003

    Есть ли у TERMINUS 20 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Создан 28 окт. 2004 г.
    Поставлен 10 нояб. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Транзакции
    • 10 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Создан 28 окт. 2004 г.
    Поставлен 10 нояб. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Транзакции
    • 10 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Создан 28 янв. 2002 г.
    Поставлен 15 февр. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    Транзакции
    • 15 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Создан 26 окт. 2001 г.
    Поставлен 14 нояб. 2001 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Транзакции
    • 14 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 19 июн. 1998 г.
    Поставлен 10 июл. 1998 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Краткое описание
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Уполномоченные лица
    • Chase Manhattan International Limited
    Транзакции
    • 10 июл. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 28 дек. 1995 г.
    Поставлен 08 янв. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Транзакции
    • 08 янв. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июн. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed
    Создан 28 дек. 1995 г.
    Поставлен 05 янв. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Краткое описание
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    Транзакции
    • 05 янв. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 июн. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Создан 26 янв. 1989 г.
    Поставлен 31 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys due or to become due from bucksmere limited to standard chartered bank as agent and trustee for the lenders under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 on any account whatsoever
    Краткое описание
    (See doc M228 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders
    Транзакции
    • 31 янв. 1989 г.Регистрация залога
    • 26 июн. 1998 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Создан 26 янв. 1989 г.
    Поставлен 31 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from bucksmere and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks and the overdraft bank under the terms of "the facilities agreement" dated 21/12/88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever.
    Краткое описание
    (See doc M217 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Транзакции
    • 31 янв. 1989 г.Регистрация залога
    • 22 янв. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 30 апр. 1981 г.
    Поставлен 13 мая 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 13 мая 1981 г.Регистрация залога
    Deed
    Создан 02 мар. 1981 г.
    Поставлен 16 мар. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from bpc LTD not exceeding £13,000,000 under the terms of a deed dated 18-12-81 & deeds supplemental thereto
    Краткое описание
    Floating charges over all see doc M79. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 16 мар. 1981 г.Регистрация залога

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0