KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииKITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00540556
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Юридический адрес
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    VENT MASTER (EUROPE) LIMITED21 июн. 1996 г.21 июн. 1996 г.
    BERISFORD BAKER STREET LIMITED01 мар. 1995 г.01 мар. 1995 г.
    BERISFORD TREASURY LIMITED10 февр. 1995 г.10 февр. 1995 г.
    BERISFORD TREASURY LIMITED09 мая 1989 г.09 мая 1989 г.
    S & W BERISFORD TREASURY LIMITED29 окт. 1987 г.29 окт. 1987 г.
    ASTON METAL CO LIMITED12 нояб. 1954 г.12 нояб. 1954 г.

    Каковы последние отчеты KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2012 г.

    Какие последние документы подавались KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    4 страницыDS01

    Отчет о капитале на 09 авг. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19

    legacy

    3 страницыSH20

    legacy

    3 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Прекращение полномочий Michael James Kachmer в качестве директора 03 апр. 2013 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01

    Назначение Graham Philip Brisley Veal на должность директора

    3 страницыAP01

    Прекращение полномочий Kevin Blades в качестве директора

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Прекращение полномочий Thomas Doerr в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Adrian David Gray на должность директора

    3 страницыAP01

    legacy

    1 страницы287

    legacy

    4 страницы363a

    legacy

    1 страницы353

    legacy

    1 страницы288c

    Кто является должностными лицами KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Секретарь компании
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Директор
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Директор
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Директор
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Секретарь
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Секретарь
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Секретарь
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Директор
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Директор
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Директор
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Директор
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Директор
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Директор
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Директор
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JONES, Eric Alan
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    Директор
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    British27290300001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Директор
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Номинированный директор
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Директор
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Директор компании
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    Директор компании
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Директор компании
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006
    S & W BERISFORD LIMITED
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    Директор компании
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    75310610001

    Есть ли у KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Создан 11 апр. 2002 г.
    Поставлен 25 апр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Транзакции
    • 25 апр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Создан 20 февр. 2002 г.
    Поставлен 08 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Транзакции
    • 08 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Создан 20 нояб. 2001 г.
    Поставлен 30 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 13 авг. 1999 г.
    Поставлен 27 авг. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    Краткое описание
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent
    Транзакции
    • 27 авг. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 авг. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of amendment.
    Создан 30 сент. 1991 г.
    Поставлен 16 окт. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90
    Краткое описание
    All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details).
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 16 окт. 1991 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 26 сент. 1990 г.
    Поставлен 09 окт. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee
    Краткое описание
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 окт. 1990 г.Регистрация залога
    • 30 янв. 1993 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 сент. 1990 г.
    Поставлен 09 окт. 1990 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Краткое описание
    Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 09 окт. 1990 г.Регистрация залога
    • 22 апр. 1995 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0