INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииINDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00548648
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    • Телевещание и трансляция телевизионных программ (60200) / Информация и связь

    Где находится INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    Юридический адрес
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 дек. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 сент. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на11 июн. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено25 июн. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на11 июн. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Уведомление о подтверждении, составленное 11 июн. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    48 страницыAA

    Назначение Zaffrin O'sullivan на должность секретаря 29 февр. 2024 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий James Henry Scorer в качестве секретаря 29 февр. 2024 г.

    1 страницыTM02

    Назначение Mr Justin Paul Smith на должность директора 02 янв. 2024 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David Mcpherson Conway в качестве директора 03 нояб. 2023 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Ms Adedigba Amanda Rawcliffe на должность директора 02 окт. 2023 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Angela Jain в качестве директора 29 сент. 2023 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 11 июн. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    48 страницыAA

    Назначение Ms Rachel Corp на должность директора 01 сент. 2022 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Deborah Mary Turness в качестве директора 31 авг. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 11 июн. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    56 страницыAA

    Назначение Ms Angela Jain на должность директора 23 нояб. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Magnus Hugh Brooke в качестве директора 23 нояб. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 11 июн. 2021 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Назначение Ms Deborah Mary Turness на должность директора 19 апр. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    49 страницыAA

    Прекращение полномочий Anna Celia Mallett в качестве директора 16 апр. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 11 июн. 2020 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мая 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    50 страницыAA

    Назначение Mr David Mcpherson Conway на должность директора 28 окт. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Bryan Robert Martin в качестве директора 27 окт. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    O'SULLIVAN, Zaffrin
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Секретарь
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    320364060001
    CORP, Rachel
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishCeo299651220001
    COX, Charles Richard
    Brewhurst Lane
    Loxwood
    RH14 0RJ Billingshurst
    Roundabout Meadow
    England
    Директор
    Brewhurst Lane
    Loxwood
    RH14 0RJ Billingshurst
    Roundabout Meadow
    England
    EnglandAustralianDirector250409140001
    LINNEBANK, Geert
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    United KingdomDutchDirector75179990001
    MULLINS, Andrew Oliver
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishDirector113403380001
    MULLINS, Kyla Lynne Anthea
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    United KingdomBritishDirector254336790001
    RAWCLIFFE, Adedigba Amanda
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishCompany Director219624480002
    SMITH, Justin Paul
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    United KingdomBritishChief Financial And Operational Officer317847600001
    SCORER, James Henry
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Секретарь
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    British54303810002
    TIMMS, Clive
    12 Forest Drive
    E12 5DF London
    Секретарь
    12 Forest Drive
    E12 5DF London
    British9997300001
    WHEATLEY, James Martyn
    Hasluck Gardens
    New Barnet
    EN5 1HS Barnet
    39
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Hasluck Gardens
    New Barnet
    EN5 1HS Barnet
    39
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British133957210001
    4TH VISCOUNT ROTHERMERE, Jonathan Harold Esmond Vere, The Right Honourable
    c/o Dmgt Plc
    2 Derry Street
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    England
    Директор
    c/o Dmgt Plc
    2 Derry Street
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    England
    EnglandBritishChairman244923430001
    BETTS, Thomas Matthew
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    United KingdomBritishAlternative Director To A Garard85937750001
    BLAND, Francis Christopher Buchan, Sir
    Blissamore Hall
    Clanville
    SP11 9HL Andover
    Hampshire
    Директор
    Blissamore Hall
    Clanville
    SP11 9HL Andover
    Hampshire
    EnglandBritishBusinessman89150480001
    BROOK, Anthony Donald
    18 Brookvale Road
    Highfield
    SO17 1QP Southampton
    Hampshire
    Директор
    18 Brookvale Road
    Highfield
    SO17 1QP Southampton
    Hampshire
    BritishDirector3581010001
    BROOKE, Magnus Hugh
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishDirector131300990001
    BROWN, Graham Roger
    c/o Dmg Media Limited
    2 Derry Street
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    United Kingdom
    Директор
    c/o Dmg Media Limited
    2 Derry Street
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector111137550001
    CAIN, Steven Anthony
    Stutton Grange Garnet Lane
    LS24 9BD Tadcaster
    North Yorkshire
    Директор
    Stutton Grange Garnet Lane
    LS24 9BD Tadcaster
    North Yorkshire
    BritishChief Executive62442000001
    CARVER, Margaret Adela Miriam
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishCompany Director101357750001
    CONWAY, David Mcpherson
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishChief Financial And Operations Director160521960002
    CRESSWELL, John
    Holly House
    Up Somborne
    SO20 6QZ Stockbridge
    Hampshire
    Директор
    Holly House
    Up Somborne
    SO20 6QZ Stockbridge
    Hampshire
    BritishDirector39795820002
    DE MOLLER, June Frances
    35 Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    Директор
    35 Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    EnglandBritishCompany Director82327930001
    DESMOND, Michael John
    5 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0NB London
    Директор
    5 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0NB London
    EnglandBritishDirector31522290002
    DUNN, Richard Johann
    14 Bolingbroke Grove
    SW11 6EP London
    Директор
    14 Bolingbroke Grove
    SW11 6EP London
    BritishDirector35783010001
    EMERY, Richard James
    The Four Sycamores Mill Road
    Shiplake
    RG9 3LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    The Four Sycamores Mill Road
    Shiplake
    RG9 3LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector44754790001
    ENGLISH, David, Sir
    15 Cowley Street
    Westminster
    SW1P 3LZ London
    Директор
    15 Cowley Street
    Westminster
    SW1P 3LZ London
    BritishChairman & Editor In Chief2547810001
    GARARD, Andrew Sheldon
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    Директор
    200 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8XZ
    EnglandBritishCompany Director135185650001
    GILBERT, Roger Neil
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    Директор
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    BritishManaging Director10438800003
    GILBERT, Roger Neil
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    Директор
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    BritishManaging Director10438800003
    GILBERT, Roger Neil
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    Директор
    16 The Chenies
    Petts Wood
    BR6 0ED Orpington
    Kent
    BritishChartered Accountant10438800003
    GORDON, David Sorrell
    Greenwood 56 Dukes Avenue
    Chiswick
    W4 2AF London
    Директор
    Greenwood 56 Dukes Avenue
    Chiswick
    W4 2AF London
    BritishChief Executive12524560001
    GRADE, Michael Ian
    Flat 18 Bevedere House
    130 2 Grosvenor Road
    SW1V 3JY London
    Директор
    Flat 18 Bevedere House
    130 2 Grosvenor Road
    SW1V 3JY London
    BritishDirector71289920013
    GREEN, Michael Anthony
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    Директор
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director33864440003
    GREEN, Michael Philip
    1 Old Barrack Yard
    SW1X 7NP London
    Директор
    1 Old Barrack Yard
    SW1X 7NP London
    BritishCompany Director37355670007
    GREGSON, Charles Henry
    Hope Farm
    The Haven
    RH14 9BN Billingshurst
    West Sussex
    Директор
    Hope Farm
    The Haven
    RH14 9BN Billingshurst
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director145678020001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Itv Broadcasting Limited
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    England
    06 апр. 2016 г.
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаRegistrable Relevant Legal Entity That Keeps Its Own Psc Register. Private Company Limited By Shares Incorporated In England And Wales.
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииCompanies House Register
    Регистрационный номер00955957
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.

    Есть ли у INDEPENDENT TELEVISION NEWS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 16 окт. 2018 г.
    Поставлен 29 окт. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    N/A.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Martyn Roy Hurd
    • Paul Flook
    • Duncan Merlin Jones
    • Lesley Ann Everett
    Транзакции
    • 29 окт. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • Более четырех уполномоченных лиц Да
    Deed of charge over credit balances
    Создан 19 февр. 2013 г.
    Поставлен 22 февр. 2013 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor, for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Details of charged accounts(s): barclays bank PLC re independent television news limited, business premium account, account number 43194949.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 22 февр. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 окт. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Account security agreement
    Создан 20 июн. 2011 г.
    Поставлен 04 июл. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the scheme and/or the trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all present and future right title and interest in and to the account 39622150 and the account balance see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • David Slesser Mccall Cbe Dl Michael Cawley Martyn Roy Hurd Duncan Merlin Jones Catherine Mayne Michael George Morris as Trustees of the Scheme
    Транзакции
    • 04 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Account security agreement
    Создан 20 июн. 2011 г.
    Поставлен 04 июл. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the scheme and/or the trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all present and future right title and interest in and to the account 39594815 and the account balance see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • David Slesser Mccall Cbe Dl Michael Cawley Martyn Roy Hurd Duncan Merlin Jones Catherine Mayne Michael George Morris as Trustees of the Scheme
    Транзакции
    • 04 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 22 янв. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security agreement
    Создан 20 июн. 2011 г.
    Поставлен 04 июл. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the scheme and/or the trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all claims or rights to or in respect of the shares and all related rights and by way of floating charge all of its claims or rights to or in respect of all permitted dividends and the company receivables see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • David Slesser Mccall Cbe Dl Michael Cawley Martyn Roy Hurd Duncan Merlin Jones Catherine Mayne Michael George Morris as Trustees of the Scheme
    Транзакции
    • 04 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 22 янв. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security agreement
    Создан 20 июн. 2011 г.
    Поставлен 04 июл. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the scheme on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of fixed charge the itn news archive (including the copyright therein, the proceeds, all the copy news archive by way of floating charge all the assets and the receivables see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • David Slesser Mccall Cbe Dl Michael Cawley Martyn Roy Hurd Duncan Merlin Jones Catherine Mayne Michael George Morris as Trustees of the Scheme
    Транзакции
    • 04 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 05 февр. 2009 г.
    Поставлен 20 февр. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Full title guarantee to the chargee fixed charge all secured assets now and in the futre vested in or owned by the chargor floating charge see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Itv Broadcasting Limited
    Транзакции
    • 20 февр. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 дек. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 15 июн. 1995 г.
    Поставлен 23 июн. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to morgan guaranty trust company of new york (the "agent"),the chargee (as security agent for the banks) any or the banks (as defined in the facility agreement dated 9TH june 1995) and/or any receiver under or in connection with the facility agreement and this debnture
    Краткое описание
    All that f/h land k/a 200 gray's inn road t/n NGL393006,l/h land k/a the industrial printing and publishing worksforming part of new printing house square gray's inn road and all that f/h land being the area of land lying beneath coley street london WC1 t/n NGL2708028 and in each case all buildings and fixtures erections fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Sumitomo Bank Limited
    Транзакции
    • 23 июн. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 июн. 1993 г.
    Поставлен 17 июн. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to morgan guaranty trust company of new york the agent, the sumitoma bank limited (as security agent for the banks and /or any receiver both terms as defined therein under the terms of the facility agreement dated 1ST june 1993 and for the debenture
    Краткое описание
    Freehold land title absolute under title no. Ngl 393006 known as 200 grays inn road and various properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Sumitomo Bank Limited (As Security Agent for the Banks)
    Транзакции
    • 17 июн. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge over cash deposit
    Создан 08 июн. 1992 г.
    Поставлен 19 июн. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £1,638,000.00
    Краткое описание
    All its right title benefit and interest in the joint interest earning deposit account in the names of stanhope grays inn limited and itn limited at barclays bank PLC,54,lombard street,london EC3.
    Уполномоченные лица
    • Stanhope Grays Inn Limited
    Транзакции
    • 19 июн. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge and assignment
    Создан 21 дек. 1990 г.
    Поставлен 10 янв. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All the interest of the company in, and all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement dated 28.10.88 relating to the itn building, 192/212 & parts of 214 grays inn road, l/b of camden & all the premises comprised therein & the company's estate & interest in every conveyance transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 10 янв. 1991 г.Регистрация залога
    • 07 мая 1992 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Aircraft mortgage
    Создан 28 сент. 1989 г.
    Поставлен 19 окт. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of mortgage the aircraft, the manuels and technical records (see form 395 for full details).
    Уполномоченные лица
    • Sds Bank LTD
    Транзакции
    • 19 окт. 1989 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 сент. 1987 г.
    Поставлен 30 сент. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Area lying beneath the roadway known as coley street which links 200 grays inn road to the industrial printing and publishing works forming part of new printing house square, grays inn road at basement level l/b of camden.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 сент. 1987 г.Регистрация залога
    • 12 нояб. 1992 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 сент. 1987 г.
    Поставлен 30 сент. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    200 grays inn road l/b of camden title no ngl 393006.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 сент. 1987 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 сент. 1987 г.
    Поставлен 30 сент. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The industrial printing & publishing works forming part of new printing house square, grays inn road l/b of camden title no ngl 265533.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 сент. 1987 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 14 сент. 1987 г.
    Поставлен 30 сент. 1987 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The bridge over the roadway known as coley street linking the f/h property 200 grays inn road to the f/h property new printing house square grays inn road l/b of camden.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 сент. 1987 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge was registered pursuant to an order of court dated 26/11/82
    Создан 29 сент. 1982 г.
    Поставлен 09 дек. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H itn house (formerly mormay house) 48 wells st 47 wells st & 1A wells building st marylebone title no ngl 67311.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1982 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge was registered pursuant to an order of court dated 26/11/82
    Создан 29 сент. 1982 г.
    Поставлен 09 дек. 1982 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H itn house (formerly mormay house) 48 wells st, 47 wells st and 1A wells building st marylebone title no ln 245627.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 дек. 1982 г.Регистрация залога
    • 29 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0