GENUS CONSULTING LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGENUS CONSULTING LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00560971
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GENUS CONSULTING LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится GENUS CONSULTING LIMITED?

    Юридический адрес
    Matrix House
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Hampshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GENUS CONSULTING LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    HTSPE LIMITED24 мар. 2004 г.24 мар. 2004 г.
    HTS DEVELOPMENT LIMITED26 мая 2000 г.26 мая 2000 г.
    HTS DEVELOPMENTS LIMITED25 апр. 2000 г.25 апр. 2000 г.
    HUNTING TECHNICAL SERVICES LIMITED04 февр. 1956 г.04 февр. 1956 г.

    Каковы последние отчеты GENUS CONSULTING LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2015 г.

    Какие последние документы подавались GENUS CONSULTING LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01
    A5AMR45M

    Прекращение полномочий Karim Bitar в качестве директора 28 июн. 2016 г.

    1 страницыTM01
    X5AI2BOX

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01

    legacy

    1 страницыSH20
    S5A2I5Q1

    Отчет о капитале на 28 июн. 2016 г.

    • Капитал: GBP 1
    4 страницыSH19
    A5A4OWIO

    legacy

    1 страницыCAP-SS
    S5A2I5PT

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA
    A51VN914

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital19 окт. 2015 г.

    Отчет о капитале на 19 окт. 2015 г.

    • Капитал: GBP 1,400,000
    SH01
    X4IC5KVC

    Изменение данных директора для Mr Denis Noonan 10 авг. 2015 г.

    2 страницыCH01
    X4F5GITK

    Изменение данных директора для Mr Stephen David Wilson 29 июн. 2015 г.

    2 страницыCH01
    X4AO02S8

    Юридический адрес изменен с Belvedere House, Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4HG на Matrix House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4DZ 29 июн. 2015 г.

    1 страницыAD01
    X4AL8TMX

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA
    A45WYTAW

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital01 окт. 2014 г.

    Отчет о капитале на 01 окт. 2014 г.

    • Капитал: GBP 1,400,000
    SH01
    X3HL7Z97

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA
    A32JGBG2

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital18 окт. 2013 г.

    Отчет о капитале на 18 окт. 2013 г.

    • Капитал: GBP 1,400,000
    SH01
    X2J8PTI3

    Назначение Cara Crichton на должность секретаря

    1 страницыAP03
    X270W5XC

    Прекращение полномочий Ian Farrelly в качестве секретаря

    1 страницыTM02
    X270W5M2

    Назначение Mr Stephen David Wilson на должность директора

    2 страницыAP01
    X2457KRC

    Прекращение полномочий John Worby в качестве директора

    1 страницыTM01
    X2457IOA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA
    A1O6CTZ5

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    X1JRARXA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA
    L13JU2R5

    Кто является должностными лицами GENUS CONSULTING LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    CRICHTON, Cara
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Секретарь
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    177792680001
    NOONAN, Denis
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Директор
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    EnglandIrishAccountant126374180003
    WILSON, Stephen David
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Директор
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director80682720001
    FAIRALL, Lawrence David
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    Секретарь
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    British41072230001
    FARRELLY, Ian Brian
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Секретарь
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    British71425280002
    HALL, Francis
    58 Pillory Street
    CW5 5BG Nantwich
    Cheshire
    Секретарь
    58 Pillory Street
    CW5 5BG Nantwich
    Cheshire
    British75404160001
    SCHOFIELD, Nigel Geoffrey
    16 High Firs Crescent
    AL5 1NA Harpenden
    Hertfordshire
    Секретарь
    16 High Firs Crescent
    AL5 1NA Harpenden
    Hertfordshire
    British31102430001
    TIMMINS, David Peter
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    Секретарь
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director96939310003
    VICKERS, Christopher John
    Cross Lanes
    Clandon Road
    GU4 7UW West Clandon
    Surrey
    Секретарь
    Cross Lanes
    Clandon Road
    GU4 7UW West Clandon
    Surrey
    British86434440001
    ACTON, Thomas Philip
    The Old Shop Farm
    Aston By Budworth
    CW9 6LT Northwich
    Cheshire
    Директор
    The Old Shop Farm
    Aston By Budworth
    CW9 6LT Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector25658700001
    BITAR, Karim
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Директор
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    United KingdomAmericanCeo162877990001
    BODEN, Martin Brett
    South House
    The Green Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    Oxford
    Директор
    South House
    The Green Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    Oxford
    BritishCfo79799440002
    BOYD, Thomas Marshall
    Gordon House
    Fern Lane
    HP17 8EL Haddenham
    Bucks
    Директор
    Gordon House
    Fern Lane
    HP17 8EL Haddenham
    Bucks
    BritishAgriculturist31102440001
    CARVELEY, John Stanley
    328 Camp Road
    AL1 5PB St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    328 Camp Road
    AL1 5PB St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant11412690001
    COLLIER, Frederick William
    101 New House Park
    AL1 1UH St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    101 New House Park
    AL1 1UH St Albans
    Hertfordshire
    BritishSoil Scientist17104520001
    DEANE, Graham Clifford
    17 Ash Close
    WD5 0DN Abbots Langley
    Hertfordshire
    Директор
    17 Ash Close
    WD5 0DN Abbots Langley
    Hertfordshire
    BritishForestry & Remote Sensing Cons18685780002
    HUNTING, Richard Hugh
    40 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    Директор
    40 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    EnglandBritishEngineer19556470001
    KELLY, Thomas John
    Overmead
    Alkington Road
    SY13 1TE Whitchurch
    Salop
    Директор
    Overmead
    Alkington Road
    SY13 1TE Whitchurch
    Salop
    United KingdomBritishAxient Director41072870001
    POTTEN, David Henry
    3 Spicer Street
    AL3 4PH St Albans
    Hertfordshire
    Директор
    3 Spicer Street
    AL3 4PH St Albans
    Hertfordshire
    BritishEconomist17104530001
    ROLLER, Michael Roy David
    Hope Cottage
    Livery Road
    SP5 1RF Salisbury
    Wiltshire
    Директор
    Hope Cottage
    Livery Road
    SP5 1RF Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director59319870004
    TIMMINS, David Peter
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    Директор
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director96939310003
    WESTERN, Stanley
    21 Hampden Road
    Flitwick
    MK45 1HX Bedfordshire
    Директор
    21 Hampden Road
    Flitwick
    MK45 1HX Bedfordshire
    BritishEnvironmentalist38165360001
    WHETNALL, Christopher Rees
    The Coach House
    Hexton Road, Lilley
    LU2 8LU Luton
    Bedfordshire
    Директор
    The Coach House
    Hexton Road, Lilley
    LU2 8LU Luton
    Bedfordshire
    BritishAgricultural Engineer67588490001
    WOOD, Richard Kenneth
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Директор
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    EnglandBritishDirector102208990001
    WORBY, John Graham
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Директор
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    United KingdomBritishAccountant137236910001

    Есть ли у GENUS CONSULTING LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Performance deposit deed
    Создан 20 янв. 2006 г.
    Поставлен 24 янв. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £29,375.00 due or to become due from the company to
    Краткое описание
    The company's interest in the rent deposit account.
    Уполномоченные лица
    • Baltimore Technologies (UK) Limited
    Транзакции
    • 24 янв. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 нояб. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 27 окт. 2005 г.
    Поставлен 04 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Транзакции
    • 04 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 нояб. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 15 нояб. 1999 г.
    Поставлен 19 нояб. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) and/or the foreign companies (as defined) or any of them to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (the "security trustee") under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any account whatsoever
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 19 нояб. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 нояб. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 15 июл. 1998 г.
    Поставлен 30 июл. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 30 июл. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 21 мар. 1995 г.
    Поставлен 24 мар. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease and this deed
    Краткое описание
    The sum of £9,250 and all interest and other monies paid or credited to the depsoit account opened or to be opened by cornhill investment properties.
    Уполномоченные лица
    • Cornhill Investment Properties Limited
    Транзакции
    • 24 мар. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 нояб. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0