GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00624468
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Юридический адрес
    Unit 2 Spinnaker Court 1c Becketts Place
    Hampton Wick
    KT1 4EQ Kingston Upon Thames
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    G-MAN PRODUCTS LIMITED31 мар. 1959 г.31 мар. 1959 г.

    Каковы последние отчеты GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2015 г.

    Какие последние документы подавались GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    9 страницыLIQ14

    Юридический адрес изменен с Castleside Ind Estate Consett Co Durham DH8 8JA на Unit 2 Spinnaker Court 1C Becketts Place Hampton Wick Kingston upon Thames KT1 4EQ 12 февр. 2018 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Отчет о состоянии дел

    8 страницыLIQ02

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации с даты начала дела 23 янв. 2018 г.

    LRESEX

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 мая 2017 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    8 страницыAA

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Christopher John Alexander в качестве директора 21 июл. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 006244680011

    1 страницыMR04

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital06 мая 2016 г.

    Отчет о капитале на 06 мая 2016 г.

    • Капитал: GBP 1,600,000
    SH01

    Назначение Mr Christopher John Alexander на должность директора 01 февр. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Регистрация обременения 006244680011, создано 01 февр. 2016 г.

    27 страницыMR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    Назначение Mr George Lambert на должность директора 27 авг. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Mark John Sargent в качестве директора 27 авг. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Регистрация обременения 006244680010, создано 27 авг. 2015 г.

    27 страницыMR01

    Назначение Mr Mark John Sargent на должность директора 06 июл. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Ian Matthews в качестве директора 06 июл. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Terence Stuart Smith в качестве директора 06 июл. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Deborah Langford в качестве директора 06 июл. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Deborah Langford в качестве секретаря 06 июл. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Кто является должностными лицами GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    LAMBERT, George
    1c Becketts Place
    Hampton Wick
    KT1 4EQ Kingston Upon Thames
    Unit 2 Spinnaker Court
    Директор
    1c Becketts Place
    Hampton Wick
    KT1 4EQ Kingston Upon Thames
    Unit 2 Spinnaker Court
    EnglandIrishDirector189607950001
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Секретарь
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    British1796200002
    LANGFORD, Deborah
    24 Park Drive
    Melton Park
    NE3 5QB Newcastle Upon Tyne
    Секретарь
    24 Park Drive
    Melton Park
    NE3 5QB Newcastle Upon Tyne
    BritishFinance Director59555400001
    ALEXANDER, Christopher John
    Castleside Ind Estate
    Consett
    DH8 8JA Co Durham
    Директор
    Castleside Ind Estate
    Consett
    DH8 8JA Co Durham
    EnglandBritishCompany Director181732380001
    ANGELL-HANSEN, Tor
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    Директор
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036160001
    BRATZ, Bjor Olaf
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    Директор
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    NorwegianDirector27403290001
    BRATZ, Bjorn Olaf
    Selby Lodge
    The Grove
    DH8 8BQ Consett
    County Durham
    Директор
    Selby Lodge
    The Grove
    DH8 8BQ Consett
    County Durham
    BritishGeneral Manager49757280001
    BRATZ, Jens Halvard
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    Директор
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    NorwegianDirector8335430001
    BRATZ, Ragnvald
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    Директор
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    NorwegianDirector8886200001
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Директор
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    BritishFinancial Director1796200002
    GRUNDY, Peter Thomas
    Garden Cottage
    Albury
    GU5 9BE Guildford
    Surrey
    Директор
    Garden Cottage
    Albury
    GU5 9BE Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector2157060001
    HARRIS, Ian Michael
    Park House
    Windlestone
    DL17 0NF Rushyford
    Co Durham
    Директор
    Park House
    Windlestone
    DL17 0NF Rushyford
    Co Durham
    BritishDirector11177600001
    HEWITT, Neil
    Westwinds
    Westerton
    DL14 8AJ Bishop Auckland
    County Durham
    Директор
    Westwinds
    Westerton
    DL14 8AJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishProjects Director65615010001
    HOLMES, Alan John
    40 Bemersyde Drive
    Jesmond
    NE2 2HJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Директор
    40 Bemersyde Drive
    Jesmond
    NE2 2HJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishMarketing Consultant23221500002
    HOLMES, Alan John
    40 Bemersyde Drive
    Jesmond
    NE2 2HJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Директор
    40 Bemersyde Drive
    Jesmond
    NE2 2HJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishMarketing Consultant23221500002
    JOHNSON, Gary
    12 Beacon Drive
    St. Peter's Riverside
    SR6 0RJ Sunderland
    Tyne And Wear
    Директор
    12 Beacon Drive
    St. Peter's Riverside
    SR6 0RJ Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritishManaging Director88044860001
    JOHNSTON, David Ian
    110 Devonshire Road
    DH1 2BH Belmont
    County Durham
    Директор
    110 Devonshire Road
    DH1 2BH Belmont
    County Durham
    BritishOperations Director59555480001
    LANGFORD, Deborah
    24 Park Drive
    Melton Park
    NE3 5QB Newcastle Upon Tyne
    Директор
    24 Park Drive
    Melton Park
    NE3 5QB Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishFinance Director59555400001
    MATTHEWS, Ian
    55 St Meddans Street
    KA10 6NN Troon
    Ayrshire
    Директор
    55 St Meddans Street
    KA10 6NN Troon
    Ayrshire
    ScotlandBritishSales Director108875800001
    MIDDLETON, Scott Andrew
    Grange Farm
    Sunniside
    DL13 4LZ Bishop Auckland
    County Durham
    Директор
    Grange Farm
    Sunniside
    DL13 4LZ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishManaging Director53720060002
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Директор
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036280001
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Директор
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036280001
    SANDOY, Karl Halvard
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    Директор
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    NorwegianManaging Director41615610001
    SARGENT, Mark John
    Donnington Park
    85 Birdham Road
    PO20 7AJ Chichester
    9
    West Sussex
    England
    Директор
    Donnington Park
    85 Birdham Road
    PO20 7AJ Chichester
    9
    West Sussex
    England
    EnglandBritishCompany Director44446550006
    SMITH, Terence Stuart
    Folley View
    Romaldkirk
    DL12 9EB Barnard Castle
    Woodlands
    County Durham
    Директор
    Folley View
    Romaldkirk
    DL12 9EB Barnard Castle
    Woodlands
    County Durham
    EnglandBritishChairman66702020002
    WILSON, Joseph Albert
    1 Elmfield Close
    SR3 3SW Sunderland
    Tyne & Wear
    Директор
    1 Elmfield Close
    SR3 3SW Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishProject Director27403260002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Grorud Group Limited
    DH8 8JA Consett
    Castleside Industrial Estate
    County Durham
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    DH8 8JA Consett
    Castleside Industrial Estate
    County Durham
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Страна регистрацииEngland & Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииRegister Of Companies In The United Kingdom
    Регистрационный номер03170904
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 01 февр. 2016 г.
    Поставлен 01 февр. 2016 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Land: fixed charge all estates or interests in any freehold and leasehold property from time to time belonging to or charged to the company, all licences and other agreements from time to time held or entered into by the company relating to land or to enter upon or use land and the proceeds of sale thereof; and. Intellectual property: fixed charge all intellectual property rights (defined as all patents, patent applications, trademarks and service marks (howsoever styled or represented), designs, design rights, copyrights, confidential information, know-how and all other intellectual property rights from time to time belonging to the company.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Castle and Lambert Limited (Company Number: 09823794)
    Транзакции
    • 01 февр. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 22 июл. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 27 авг. 2015 г.
    Поставлен 11 сент. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Land: fixed charge all estates or interests in any freehold and leasehold property from time to time belonging to or charged to the company, all licences and other agreements from time to time held or entered into by the company relating to land or to enter upon or use land the proceeds of sale thereof;. Intellectual property: fixed charge all intellectual property rights from time to time belonging to the company. (For definition of intellectual property rights, please refer to the deed).
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Arkle Acquisitions Limited
    Транзакции
    • 11 сент. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    Debenture
    Создан 29 мая 1996 г.
    Поставлен 12 июн. 1996 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 29 мая 1996 г.
    Поставлен 08 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • 3I Group PLC
    Транзакции
    • 08 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental group cross guarantee and debenture
    Создан 27 янв. 1992 г.
    Поставлен 14 февр. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Краткое описание
    See form 395 ref M146 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Den Norske Bank As
    Транзакции
    • 14 февр. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мая 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Supplemental group cross guarantee and debenture
    Создан 27 янв. 1992 г.
    Поставлен 28 янв. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Краткое описание
    See form 395 ref M490C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Den Norske Bank As
    Транзакции
    • 28 янв. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 нояб. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental group cross guarantee indemnity and debenture
    Создан 27 янв. 1992 г.
    Поставлен 28 янв. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Den Norske Bank As
    Транзакции
    • 28 янв. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 нояб. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Group cross-guarantee indemnity and debenture.
    Создан 28 февр. 1991 г.
    Поставлен 08 мар. 1991 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Den Norske as London Branch
    Транзакции
    • 08 мар. 1991 г.Регистрация залога
    • 05 нояб. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 16 дек. 1988 г.
    Поставлен 03 янв. 1989 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to a facility letter dated 16/12/88 and this debenture on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Bergen Bank a/S.
    Транзакции
    • 03 янв. 1989 г.Регистрация залога
    • 05 нояб. 1997 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 28 апр. 1988 г.
    Поставлен 17 мая 1988 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Bergen Bank
    Транзакции
    • 17 мая 1988 г.Регистрация залога
    Fixed and floating charge
    Создан 07 сент. 1981 г.
    Поставлен 15 сент. 1981 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed charge on all book debts and other debts due owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 15 сент. 1981 г.Регистрация залога

    Есть ли у GRORUD HOLDINGS (U.K.) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    23 янв. 2018 г.Начало ликвидации
    07 дек. 2018 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Adam Solomon Nakar
    Unit 2 Spinnaker Court 1c Becketts Place
    Hampton Wick
    KT1 4EQ Kingston Upon Thames
    Практик
    Unit 2 Spinnaker Court 1c Becketts Place
    Hampton Wick
    KT1 4EQ Kingston Upon Thames

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0